NCN 9 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNCN 9 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01399139
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NCN 9 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    NCN 9 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2 Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NCN 9 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    WORLD CLASS LEARNING LIMITED০৭ অক্টো, ১৯৯৭০৭ অক্টো, ১৯৯৭
    NOVARA LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১

    NCN 9 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৯ মার্চ, ২০১৩

    NCN 9 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    NCN 9 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ০২ সেপ, ২০১৪ তারিখে Mr Timothy John Kowalski-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ সেপ, ২০১৪

    ০৩ সেপ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 193,100
    SH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ আগ, ২০১৩

    ১৯ আগ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 193,100
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Ivan Bolton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ আগ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed world class learning LIMITED\certificate issued on 08/08/12
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name০৮ আগ, ২০১২

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৭ জুন, ২০১২

    RES15
    change-of-name০৮ আগ, ২০১২

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01

    ২৭ জুল, ২০১২ তারিখে Mr Timothy John Kowalski-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Agreement 27/06/2012
    RES13

    সচিব হিসাবে Mark Ashcroft-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০১ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Ivan Bolton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Credit agreement 08/02/2011
    RES13

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০২ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ আগ, ২০১০ তারিখে Dr Ivan Joseph Bolton-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পরিচালক হিসাবে Christopher Hinton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Timothy John Kowalski-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    NCN 9 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165369240001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish15967010001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    সচিব
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    British14333000007
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    সচিব
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    British78151560001
    PIGGOTT, Richard Courtney
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    সচিব
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    British112085820001
    TAYLOR, Frank Brownrigg
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    সচিব
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    British57228790001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    CHAPMAN, Richard Jonathan Edward
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    পরিচালক
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    British14871980001
    CHERRY, Anthony Peter
    285 Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0RR Beverley
    North Humberside
    পরিচালক
    285 Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0RR Beverley
    North Humberside
    British27289350001
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    পরিচালক
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    FORGHAM, John Anthony
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    পরিচালক
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    British33338170001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    পরিচালক
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    পরিচালক
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    JOHNSON, David Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish157156750001
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    পরিচালক
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    MACEY, David Charles
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish91745430001
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    পরিচালক
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    British81630780001
    WOOD, Nicholas
    27 Asher Street
    Felling
    NE10 0AY Gateshead
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    27 Asher Street
    Felling
    NE10 0AY Gateshead
    Tyne & Wear
    British15885680001
    WOOD, Stephen
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    পরিচালক
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    British33636730001

    NCN 9 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns an agreement being any of the existing facility agreement the new super senior credit agreement the revolving credit agreement and the ancillary facility agreements see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Deed of accession to the security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    FR60 injection moulding machine number 117816 FR60 injection moulding machine number 117723 FR60 injection moulding machine number 117813 KM60 injection moulding machine number 60077 MS120 injection moulding machine number 70741.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Corporate mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 3.2.87
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F.R. 60 injection moulding machine serial no 117805 two injection moulding tools for 9CM petri dishes manufactures by exfaleoha as per orrembley jrawing number 1.899/900-10-86.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Corporate mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 4TH jan 1988
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Bekum blow moulding machine bae - 1 serial no. 27712689 (see form 395-ref: M218- for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Corporate mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 16 sept. 1982
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    One blav moulding machine type UK 1-0,7. one piovan chiller model rcn 120/10 serial no 01300 (see M17 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The goods (herinafter descreibed) the benefit of all contracts, conditionswarranties and agreements all logbooks maintenance records record books and other documents relating to the goods any moneys payable to the company for orin connection with a sale or proposed sale of of any of the goods. 1-Off model s-12 injection bion moulding machine 1-off chiller, 1-off product conveyor(lessana supplied) as described in contract no b 600305 dated 14/09/82.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000 and other monies due under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plant & machhinery at unit 9 phase 111 algernon industrial estate shiremoor tyne & wear. Floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tyne and Wear County Council
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capitals all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জানু, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0