HEY (UK) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHEY (UK) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01414745
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HEY (UK) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    HEY (UK) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HEY (UK) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HEY SOFT DRINKS (U.K.) COMPANY LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১

    HEY (UK) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    HEY (UK) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    HEY (UK) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ ডিসে, ২০১৪

    ১৮ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 39,554
    SH01

    ২৯ জুল, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Sunita Kaushal এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ ডিসে, ২০১৩

    ১৭ ডিসে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 39,554
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে David Caldecott এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Mr Colin Elliot-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ ডিসে, ২০১২ তারিখে Mr David Gareth Caldecott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৫ নভে, ২০১২ তারিখে Mr Gareth Caldecott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ ডিসে, ২০১১ তারিখে Mr Gareth Caldecott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০৫ ডিসে, ২০১১ তারিখে Mr Andrew Maxwell Coppel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৫ ডিসে, ২০১১ তারিখে Sunita Kaushal-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    HEY (UK) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    পরিচালক
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish163106000001
    ELLIOT, Colin David
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    পরিচালক
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish178756480001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    সচিব
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    British123440090026
    KAUSHAL, Sunita
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    সচিব
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    158956040001
    RAMSBOTTOM, Peter
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    সচিব
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    British881150001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    কর্পোরেট সচিব
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    পরিচালক
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BREARLEY, John Richard
    206 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8TX Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    206 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8TX Stockport
    Cheshire
    British1575980001
    CALDECOTT, David Gareth
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    পরিচালক
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    EnglandBritish73603940004
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    পরিচালক
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish123440090026
    ENGLEFIELD, Edward Ashton
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    British35176020001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    LISTER, Steven Bernard Lewis
    Keepers Cottage
    Ashwith By Pilsley
    S45 8AN Chesterfield
    পরিচালক
    Keepers Cottage
    Ashwith By Pilsley
    S45 8AN Chesterfield
    British10137610001
    LONGDEN, John David
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish40890250001
    MARTLAND, David James
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    পরিচালক
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    British35477380001
    MCEVOY, John James
    17 Grangeway
    Handforth
    SK9 3HY Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    17 Grangeway
    Handforth
    SK9 3HY Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish48091070001
    PARKINSON, Joseph Edward
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    পরিচালক
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    United KingdomBritish4553470004
    RAMSBOTTOM, Peter
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    British881150001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    পরিচালক
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SINGLETON, Paul James
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    British79357110001
    SPIEGELBERG, Anthony William Assheton
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish24626450001
    WHITE, Christopher Geoffrey
    Woodbine Brown Heath Road
    Christleton
    CH3 7PN Chester
    Cheshire
    পরিচালক
    Woodbine Brown Heath Road
    Christleton
    CH3 7PN Chester
    Cheshire
    British58547200001

    HEY (UK) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Third supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the chargee the principal of and interest on the stock, being £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 of the greenalls group PLC and any further debenture stock of the greenalls group PLC created or issued pursuant to clause 3 of the principal trust deed, and all other monies intended to be secured by the principal trust deed dated 5 june 1991, any deed expressed to be supplemental thereto and any other deed or instrument conferring rights on the chargee executed or entered into pursuant to the principal trust deed or any deed supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The undertaking and all the property and assets present and future wherever situated (including any uncalled capital) of the company by way of first floating charge.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent.(formerly 10 1/4 per cent) debenture stock 2017 (repayable on 23RD june 2017 or such earlier date as the security constituted by the trust deed the supplemental trust deed and the second supplemental trust deed becomes enforceable and the trustee determines or becomes bound to enforce the same) and of any moneys intended to be secured by the second supplemental trust deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land k/as depot mangham road barbot hall industrial estate rotherham south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold lands being depot,mangham road,barbot hall industrial,rotherham,south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ ফেব, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Estate right title or interest (if any) or in a plot of land situate on the east side of skinner lane pontefract west yorkshire including beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings situate off bondgate,knottingley road and atkinson lane. Pontefract t/n wyk 339842 and plot of land situate off bondgate,knottingley road including interest in property or in the proceeds of sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land in barrys lane scarborough north yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Two freehold plots of land one situate between westfield road and holm flatt street in parkgate rotherham with the depot and offices erected thereon or on some part thereof and theother situate some short distance to the north east and also being in westgage with the buildings erected thereon or on some part thereof and used as a garage and store.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and building at spawd bone lane,knottingley,west yorkshire.t/no.wyk 21390 and part of t/no.wyk 427817.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at carnaby road bridlington T.no. Hs 1667.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings off station road,ushaw moor,county durham.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings situate at skinner lane pontefract west yorkshire T.no wyk 20616.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings spawd bone lanes knottingley,west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a on being land and buildings on the south side of lancaster road carnaby bridlington humberside t/n H.S. 1667 registered at H.M. land registry.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুন, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ফেব, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h land and buildings on the east side of skinner lane, pontefract, west yorkshire title no wyk 20616.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ফেব, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The right title or interest of hey soft drinks (UK) company limited of and in a plot of land situate on the east side ofskenner lane, pontefract, west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0