PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01428848
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    BENEDICT MACKENZIE
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৫

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    ১২ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১২ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৩ মার্চ, ২০০৮ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    সচিব
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New ZealanderCompany Director126903810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    পরিচালক
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOtherCompany Director123425810001
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    সচিব
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    British8606990001
    BURTON, Steven John
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    সচিব
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    BritishFinance Director58305750001
    GREGORY, Andrew Nicholas
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    সচিব
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    BritishDirector63728320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    সচিব
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    সচিব
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    OtherCompany Director123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    সচিব
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    সচিব
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director115960470001
    LIEVERS, Richard
    11 Ruskin Avenue
    Syston
    LE7 2BY Leicester
    সচিব
    11 Ruskin Avenue
    Syston
    LE7 2BY Leicester
    BritishCompany Director53451700001
    LLOYD, Roger William
    10 Ryegrass Road
    Oakwood
    DE21 2TX Derby
    সচিব
    10 Ryegrass Road
    Oakwood
    DE21 2TX Derby
    BritishAccountant47766140001
    MINIKIN, Claire Louise
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    সচিব
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    British77770730001
    SOULSBY, James Andrew
    Bramshott Lodge
    Woolmer Hill
    GU27 1QA Haslemere
    Surrey
    সচিব
    Bramshott Lodge
    Woolmer Hill
    GU27 1QA Haslemere
    Surrey
    British38342300002
    WALKER, Heath Lee
    47 Sedgefield Drive
    Herondale
    LE7 1YU Syston
    Leicestershire
    সচিব
    47 Sedgefield Drive
    Herondale
    LE7 1YU Syston
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant43205360001
    WARRINGTON, Lorri
    Applecroft
    Plaistow Road Ifold
    RH14 0TU Billingshurst
    West Sussex
    সচিব
    Applecroft
    Plaistow Road Ifold
    RH14 0TU Billingshurst
    West Sussex
    British84757210001
    BITTLESTON, Timothy Steven
    The Chimneys
    73 Station Road
    DE13 8DS Barton Under Needwood
    Staffordshire
    পরিচালক
    The Chimneys
    73 Station Road
    DE13 8DS Barton Under Needwood
    Staffordshire
    BritishCompany Director74438980001
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    পরিচালক
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector8606990001
    BURTON, Steven John
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director58305750001
    CANNING, Phillip Francis
    Roeside
    Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith
    SK23 9UL High Peak
    Derbyshire
    পরিচালক
    Roeside
    Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith
    SK23 9UL High Peak
    Derbyshire
    BritishDirector70379550001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    পরিচালক
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New ZealanderCompany Director122786180001
    GEE, Peter Peregrine Simpson
    Rowells Lodge Ayston Road
    Ridlington
    LE15 9AH Oakham
    Leicestershire
    পরিচালক
    Rowells Lodge Ayston Road
    Ridlington
    LE15 9AH Oakham
    Leicestershire
    BritishDirector68168890001
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    পরিচালক
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    CanadianCompany Director123427350001
    GREGORY, Andrew Nicholas
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    BritishDirector63728320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector109926660001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director115960470001
    LIEVERS, Richard
    11 Ruskin Avenue
    Syston
    LE7 2BY Leicester
    পরিচালক
    11 Ruskin Avenue
    Syston
    LE7 2BY Leicester
    BritishCompany Director53451700001
    LLOYD, Roger William
    10 Ryegrass Road
    Oakwood
    DE21 2TX Derby
    পরিচালক
    10 Ryegrass Road
    Oakwood
    DE21 2TX Derby
    BritishAccountant47766140001
    MCLAREN, Michael Gerald
    October House 4 The Mount Drive
    RH2 0EZ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    October House 4 The Mount Drive
    RH2 0EZ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant68561640002
    MEADE, Michael Gerald
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    পরিচালক
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    EnglandBritish,IrishFinance Director142059750001
    MITCHELL, Robert Neil Whyte
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director116745740001
    MORCOMBE, Alan William
    Waverley House
    Kitcombe Wood
    GU34 3ND Faringdon
    Hampshire
    পরিচালক
    Waverley House
    Kitcombe Wood
    GU34 3ND Faringdon
    Hampshire
    BritishCompany Director32807230004
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RANDALL, Martin Keith
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritishGroup Finance Director40012240002
    TAYLOR, Keith Wilhall
    Dove Cottage
    Sly Corner Lee Common
    HP16 9LD Great Missenden
    Bucks
    পরিচালক
    Dove Cottage
    Sly Corner Lee Common
    HP16 9LD Great Missenden
    Bucks
    EnglandBritishCompany Director119095470001
    THOMPSON, Richard James
    19 Fairfields Drive
    Ravenshead
    NG15 9HR Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    19 Fairfields Drive
    Ravenshead
    NG15 9HR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishFinance Director64550460002

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Stead & Simpson Group Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including trade and tenant's fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the guarantee & debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Apax Funds Nominees Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    83 melton road, west bridgford, nottingham and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন

    PIQUET COMPUTER SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৭ ফেব, ২০১০ভেঙে গেছে
    ১৩ মার্চ, ২০০৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon James Underwood
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    অভ্যাসকারী
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0