CONNILL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCONNILL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01437973
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CONNILL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    CONNILL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CONNILL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LINCOLN HANNAH LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১
    SWANPEARL LIMITED১৮ জুল, ১৯৭৯১৮ জুল, ১৯৭৯

    CONNILL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    CONNILL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২০ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২০ জুল, ২০১০ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জুল, ২০১০

    ০২ জুল, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 20,000
    SH01

    ১৫ মে, ২০১০ তারিখে Giovanni Stoppiello-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৫ মে, ২০১০ তারিখে Alison Mary Fortescue-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    পৃষ্ঠা363(288)

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    CONNILL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FORTESCUE, Alison Mary
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    সচিব
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    British74955570002
    STOPPIELLO, Giovanni
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    পরিচালক
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritishFinancial Controller105330200001
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    সচিব
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    British7332320001
    BOSSEY, Kelvin Charles
    Kerala 38 Ashley Road
    KT12 1HS Walton On Thames
    Surrey
    সচিব
    Kerala 38 Ashley Road
    KT12 1HS Walton On Thames
    Surrey
    BritishCompany Secretary12989220003
    GORDON, John
    54 Brunswick Gardens
    W8 4AN London
    সচিব
    54 Brunswick Gardens
    W8 4AN London
    British32801950001
    ROBINSON, Sarah Nicole
    27 Culverden Road
    SW12 9LT London
    সচিব
    27 Culverden Road
    SW12 9LT London
    British11406070001
    BEATTIE, James Elliot
    Fir Trees
    High Street
    TN15 0AG Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Fir Trees
    High Street
    TN15 0AG Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector70885370001
    BOSSEY, Kelvin Charles
    Kerala 38 Ashley Road
    KT12 1HS Walton On Thames
    Surrey
    পরিচালক
    Kerala 38 Ashley Road
    KT12 1HS Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary12989220003
    BROOKES, Nicholas George
    53 Wildcroft Manor
    Putney
    SW15 3TT London
    পরিচালক
    53 Wildcroft Manor
    Putney
    SW15 3TT London
    BritishChief Executive64264520004
    GIBSON, William Knatchbull, The Honourable
    46 Victoria Road
    W8 5RQ London
    পরিচালক
    46 Victoria Road
    W8 5RQ London
    United KingdomBritishNewspaper Director9970260002
    GORDON, John
    54 Brunswick Gardens
    W8 4AN London
    পরিচালক
    54 Brunswick Gardens
    W8 4AN London
    BritishCompany Director32801950001
    HALL, David James
    33 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DP London
    পরিচালক
    33 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DP London
    BritishChartered Accountant9806710001
    KING, John
    22 Park Road
    TW10 6NS Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    22 Park Road
    TW10 6NS Richmond
    Surrey
    UsaManaging Director60883340001
    LEACH, Graham
    Chester House
    237 Upper Chobham Road
    GU15 1HB Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    Chester House
    237 Upper Chobham Road
    GU15 1HB Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant55922930001
    LEVIN, Dan
    11 St Johns Wood Terrace
    NW8 6JJ London
    পরিচালক
    11 St Johns Wood Terrace
    NW8 6JJ London
    BritishDirector6481680001
    MILLER, Alan Charles
    39 Russell Road
    Moor Park
    HA6 2LP Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    39 Russell Road
    Moor Park
    HA6 2LP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishFinance Director9806700005
    REYNOLDS, Stephen Paul
    1 Flatwood
    Noble Tree Road
    TW11 8ND Hildenborough
    Kent
    পরিচালক
    1 Flatwood
    Noble Tree Road
    TW11 8ND Hildenborough
    Kent
    United KingdomBritishDirector54899660001
    RUBIN, Mark Elliot
    9 The Heath
    WD7 7DF Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 The Heath
    WD7 7DF Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant95475630001

    CONNILL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to the chargee (as custodian for apax 1V and apax ventures 1V international partners LP) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Apax Funds Nominees Limited(As Custodian for Apax Ventures 1V and Apax Ventures 1V International Partners LP)
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    89 worship street l/b of hackney.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M27). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CONNILL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৭ এপ্রি, ২০১১ভেঙে গেছে
    ২০ জুল, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    অভ্যাসকারী
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0