DECTON INVESTMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDECTON INVESTMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01447579
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DECTON INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম
    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    DECTON INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DECTON INVESTMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PENTNEY PROPERTY SERVICES LIMITED১৮ মে, ১৯৮৯১৮ মে, ১৯৮৯
    HOLLYHOCK PROPERTIES LIMITED০৭ সেপ, ১৯৭৯০৭ সেপ, ১৯৭৯

    DECTON INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০১০

    DECTON INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ নভে, ২০১১

    ২২ নভে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,800
    SH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Trevor Pass এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২০ নভে, ২০০৯ তারিখে Mr Charles Stephen Beal-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২০ নভে, ২০০৯ তারিখে Trevor Pass-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২০ নভে, ২০০৯ তারিখে James Edward Lee-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    DECTON INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LEE, James Edward
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    সচিব
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    BritishAccountant10085240001
    BEAL, Charles Stephen
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    পরিচালক
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    UsaBritishCertified Accountant10085250004
    BEAL, Peggy
    30952 Via Mirador
    San Juan
    92675 Capistrano
    California
    Usa
    সচিব
    30952 Via Mirador
    San Juan
    92675 Capistrano
    California
    Usa
    British18655620006
    LEE, James Edward
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    সচিব
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    British10085240001
    SANDERSON, Barry
    8 Cornwall Road
    DN22 6SH Retford
    Nottinghamshire
    সচিব
    8 Cornwall Road
    DN22 6SH Retford
    Nottinghamshire
    BritishAccountant37791510001
    BEAL, Rodney
    26 Fernbank Drive
    Eckington
    S21 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    26 Fernbank Drive
    Eckington
    S21 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishEngineer71868590001
    BRADLEY, Brian
    98 Heath Road
    Holmewood
    S42 5SH Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    98 Heath Road
    Holmewood
    S42 5SH Chesterfield
    Derbyshire
    BritishEngineer10431110001
    LEE, James Edward
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    BritishAccountant10085240001
    PASS, Trevor
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    পরিচালক
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    United KingdomBritishEngineer10085260006
    VALENTINE, Keith
    8 Kestrel Avenue
    Thorpe Hesley
    S61 2TT Rotherham
    South Yorkshire
    পরিচালক
    8 Kestrel Avenue
    Thorpe Hesley
    S61 2TT Rotherham
    South Yorkshire
    BritishEngineer10431120001

    DECTON INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F.h broombank park site and field equipment at broombank park sheepbridge chesterfield derbyshire part t/n DY163115. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold property known as land and buildings at broombank park known as hydraulic shop sheepbridge chesterfield derbyshire title number DY215498. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings at broombank park road, sheepbridge, chesterfield t/no: dy 207905.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and broomco (489) limited under the terms of the three agreements dated 16/8/91 and under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property at broombank road, sheepbridge chesterfield together with all buildings & fixtures (excluding tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Broomco (479) Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and broomco (489) limited under the terms of the three agreements dated 16/8/91 and under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property at broombank road, sheepbridge chesterfield together with all buildings & fixtures (excluding tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Broomco (479) Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property situate at sheepbridge works broombank road, chesterfield derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H premises k/a part of sheepbridge works, broombank road sheepbridge, chesterfield, derbyshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0