CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01448409
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বিজ্ঞাপন এজেন্সি (73110) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Mazars Llp, 30
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SCORE OUTDOOR (MIDLANDS) LIMITED০৬ সেপ, ১৯৯৯০৬ সেপ, ১৯৯৯
    VISION POSTERS LIMITED১৩ সেপ, ১৯৭৯১৩ সেপ, ১৯৭৯

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৯

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৭ সেপ, ২০২২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১১ মে, ২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD থেকে C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey London EC4M 7AUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 33 Golden Square London W1F 9JT এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    ০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 33 Golden Square London W1F 9JT থেকে Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DDপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    7 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৮ সেপ, ২০২১ তারিখে

    LRESSP

    ০৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Clear Channel Overseas Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    ০৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Clear Channel Uk Limited এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ৩১ জানু, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২২ ডিসে, ২০২০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.01
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium account of the company of £20,000 be cancelled in it's entirety. 15/12/2020
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৪ মে, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Byron Kee Chye Hoo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ মে, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Adam Paul Raymond Tow-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জানু, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জানু, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জানু, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১২ ফেব, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Clear Channel Uk Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COCHRANE, Justin Malcolm Brian
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    পরিচালক
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    EnglandEnglish110390650002
    TOW, Adam Paul Raymond
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    পরিচালক
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    EnglandBritish66766420004
    ANDREWS, Nick
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    সচিব
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    British109746840001
    BEW, Gerard Francis
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    সচিব
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    British11996520001
    EMBREY, Jacqueline Gaylor
    18 Crown Lane
    Four Oaks
    B74 4SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    18 Crown Lane
    Four Oaks
    B74 4SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British46477960001
    EMENY, Selina Holliday
    16 Priory Road
    Kew
    TW9 3DF Richmond
    Surrey
    সচিব
    16 Priory Road
    Kew
    TW9 3DF Richmond
    Surrey
    British76404320002
    TERRY, Philip
    2 Bluebird Close
    WS14 9YL Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    2 Bluebird Close
    WS14 9YL Lichfield
    Staffordshire
    British76924060001
    ANDREWS, Nicholas James
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    পরিচালক
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish168572900001
    ATKINSON, Robert Nigel
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    পরিচালক
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish128922360001
    BEVAN, Jonathan David
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    পরিচালক
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    United KingdomBritish110358490001
    BEW, Gerard Francis
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    পরিচালক
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    EnglandBritish11996520001
    BOWMAN, John Reid
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    পরিচালক
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritish79292840001
    FINDLAY, Richard
    Woodville 20 Laverockbank Road
    EH5 3DE Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    Woodville 20 Laverockbank Road
    EH5 3DE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish35695630001
    FRANCE, Julie
    10 Park Avenue
    SW14 8AT London
    পরিচালক
    10 Park Avenue
    SW14 8AT London
    EnglandBritish110526070001
    GEORGE, Stephen Terence
    5 Wood Lane
    Streetly
    B74 3LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    5 Wood Lane
    Streetly
    B74 3LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British24649850001
    HOO, Byron Kee Chye
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    পরিচালক
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    EnglandBritish214640470001
    O'HARA, Henry John
    9 Croftdown Road
    B17 8RA Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    9 Croftdown Road
    B17 8RA Birmingham
    West Midlands
    British11996550003
    OLIVER, David Henry Maxwell
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    পরিচালক
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish67052550001
    SPRING, Stephanie
    Courtnell Street
    W2 5BX London
    34
    পরিচালক
    Courtnell Street
    W2 5BX London
    34
    EnglandBritish102849950001
    WILSON, Alan Raeburn
    11 Inchcolm Terrace
    EH30 9NA South Queensferry
    West Lothian
    পরিচালক
    11 Inchcolm Terrace
    EH30 9NA South Queensferry
    West Lothian
    British33799400001

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Clear Channel Overseas Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    ০৩ মার্চ, ২০২১
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House Uk
    নিবন্ধন নম্বর01441672
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    Clear Channel Uk Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    ১২ ফেব, ২০১৮
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEnglish Law
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর950526
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।
    Clear Channel Central Limited
    Deerdykes View
    Cumbernauld
    G68 9HN Glasgow
    119
    Scotland
    ৩১ জানু, ২০১৭
    Deerdykes View
    Cumbernauld
    G68 9HN Glasgow
    119
    Scotland
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশScotland
    আইনি কর্তৃপক্ষScottish Law
    নিবন্ধিত স্থানUk
    নিবন্ধন নম্বরSc198208
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 61 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM394463 and proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 60 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM379419 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 3/4/5 water court,36 water street,birmingham west midlands t/n WM473698 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    61 charlotte street birmingham west midlands.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • T S B Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Units 3, 4 and 5 lansdowne house, (otherwise known as water court) water street, birmingham, west midlands.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • T S B Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    60 charlotte street birmingham west midlands.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • T S B Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • T S B Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property 60 and 61 charlotte street, birmingham west midlands t/ns wm 379419 and wm 394463 together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৪ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H units 3, 4 & 5 lansdowne house, water street birmingham W. midlands & goods & goodwill (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H three stoney office premises known as 61 charlotte street, birmingham west midlands.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich General Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property being part of 57/61 charlotte street, birmingham.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৪ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Stocks, shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৪ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৮ সেপ, ২০২১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১২ মার্চ, ২০২৪ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    অভ্যাসকারী
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    অভ্যাসকারী
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0