EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01450193
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • যন্ত্রপাতি (25620) / উৎপাদন

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o C/O
    KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED
    1 City Road East
    M15 4PN Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৪

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    16 পৃষ্ঠাLIQ14

    ২৯ অক্টো, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    ১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Griffin Court Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancs M3 5EQ থেকে C/O C/O 1 City Road East Manchester M15 4PNপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    13 পৃষ্ঠা4.68

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    ১১ নভে, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester M3 5EQ থেকে Griffin Court Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancs M3 5EQপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    11 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন ৩০ অক্টো, ২০১৪ তারিখে

    LRESEX

    ২৭ অক্টো, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Lipton Close St Johns Road Bootle Liverpool Merseyside L20 8PU থেকে Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester M3 5EQপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ জুল, ২০১৪

    ১১ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০১১ তারিখে Mr Michael Hassall-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ ডিসে, ২০১০ তারিখে Mr Ian Richard Holder Slaughter-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ ডিসে, ২০১০ তারিখে Mr Stephen Paul Hassall-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SLAUGHTER, Ian Richard Holder
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    British39851430003
    HASSALL, Michael
    Warwick Road
    Hale
    WA15 9NS Altrincham
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Warwick Road
    Hale
    WA15 9NS Altrincham
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish48866820004
    HASSALL, Stephen Paul
    Brow
    7 Victoria Way
    L37 1YF Formby
    Berry
    Merseyside
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brow
    7 Victoria Way
    L37 1YF Formby
    Berry
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish7207310010
    SLAUGHTER, Ian Richard Holder
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish39851430003
    CHISNELL, Paul Rowland Robert Kenneth
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    সচিব
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    British47197920001
    HASSALL, Edward William
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    সচিব
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    British7207300001
    HASSALL, Gillian
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    সচিব
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    British32812860003
    CHISNELL, Paul Rowland Robert Kenneth
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish47197920001
    HASSALL, Edward William
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    পরিচালক
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    British7207300001
    HASSALL, Gillian
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    পরিচালক
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    British32812860003
    HASSALL, Michael
    1 Hornbeam Drive
    CW8 2GA Hartford
    Cheshire
    পরিচালক
    1 Hornbeam Drive
    CW8 2GA Hartford
    Cheshire
    British48866820001

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee by the company whether pursuant to a loan agreement dated 24TH march 2000 or the guarantee & debenture or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial Mezzanine Fund L.P.
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Trustees of the Edwards Engineering (L'pool) LTD. Pension Plan
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • S.P.Hassall
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৮৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    ব্যবসায়
    • ১২ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জানু, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book debts and other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জানু, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুন, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুন, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩০ অক্টো, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০২ এপ্রি, ২০১৮ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Alan David Fallows
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester
    অভ্যাসকারী
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0