TELE-CINE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTELE-CINE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01471324
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TELE-CINE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9220) /

    TELE-CINE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Stephen Street
    W1T 1AT London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TELE-CINE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CALOAK LIMITED০৭ জানু, ১৯৮০০৭ জানু, ১৯৮০

    TELE-CINE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    TELE-CINE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ আগ, ২০১১

    ১৬ আগ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 575,002
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    সচিব হিসাবে James Watson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৫ নভে, ২০০৯ তারিখে William Niles-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৫ নভে, ২০০৯ তারিখে James Neil Watson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    TELE-CINE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NILES, William
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    পরিচালক
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    United StatesAmericanGeneral Counsel65159400001
    BROCKSOM, David Graham
    Greenloaning
    10 Greenhurst Lane Oxted
    RH8 0LB Hurst Green
    Surrey
    সচিব
    Greenloaning
    10 Greenhurst Lane Oxted
    RH8 0LB Hurst Green
    Surrey
    BritishChartered Accountant56519100003
    EASTMAN, Emma Nicole
    Flat 3
    111 Clarendon Road
    W11 4JG London
    সচিব
    Flat 3
    111 Clarendon Road
    W11 4JG London
    British76154110001
    HALL, Graham John
    52 Hayes Road
    BR2 9AA Bromley
    Kent
    সচিব
    52 Hayes Road
    BR2 9AA Bromley
    Kent
    United KingdomDirector47622960001
    IGOE, Nicholas
    1 Rose Cottages
    SW14 8PG London
    সচিব
    1 Rose Cottages
    SW14 8PG London
    British1056860001
    WATSON, James Neil
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    সচিব
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    BritishSolicitor71254060003
    WILLSDON, Nigel John
    39
    Crescent Road
    TN1 2LZ Tunbridge Wells
    Kent
    সচিব
    39
    Crescent Road
    TN1 2LZ Tunbridge Wells
    Kent
    BritishAccountant59239750002
    BROCKSOM, David Graham
    Greenloaning
    10 Greenhurst Lane Oxted
    RH8 0LB Hurst Green
    Surrey
    পরিচালক
    Greenloaning
    10 Greenhurst Lane Oxted
    RH8 0LB Hurst Green
    Surrey
    BritishChartered Accountant56519100003
    DOWNING, Terry William
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    পরিচালক
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandBritishChief Financial Officer109287950001
    EMERSON, Jeffrey Conway
    41 Murray Road
    W5 4XR London
    পরিচালক
    41 Murray Road
    W5 4XR London
    AmericanDirector66070590001
    GRAVES, John Wolcott
    Mole End Holly Cottages
    Wormley Lane Hambledon
    GU8 4HB Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Mole End Holly Cottages
    Wormley Lane Hambledon
    GU8 4HB Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director47122450001
    HALL, Graham John
    52 Hayes Road
    BR2 9AA Bromley
    Kent
    পরিচালক
    52 Hayes Road
    BR2 9AA Bromley
    Kent
    EnglandUnited KingdomDirector47622960001
    HASSANEIN, Salah Mohammed
    2318 Ocean Front
    92014 Del Mar
    California
    U S A
    পরিচালক
    2318 Ocean Front
    92014 Del Mar
    California
    U S A
    AmericanPresident/Executive42656500002
    HUSAIN, Saleem
    60 Raleigh Drive
    N20 0UU London
    পরিচালক
    60 Raleigh Drive
    N20 0UU London
    EnglandBritishManaging Director21881910002
    IGOE, Nicholas
    1 Rose Cottages
    SW14 8PG London
    পরিচালক
    1 Rose Cottages
    SW14 8PG London
    BritishChartered Accountant1056860001
    KIRSCH, Raymond
    Eastbridge House Pankridge Street
    Crondall
    GU10 5RH Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Eastbridge House Pankridge Street
    Crondall
    GU10 5RH Farnham
    Surrey
    BritishPublisher7541640001
    OHAGAN, Paul Alan Peter
    River House
    12 St Peters Road
    TW1 1QX St Margarets
    Middlesex
    পরিচালক
    River House
    12 St Peters Road
    TW1 1QX St Margarets
    Middlesex
    BritishCompany Director18076030002
    PARKER, David
    20 Barrington Road
    CB2 6SJ Foxton
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    20 Barrington Road
    CB2 6SJ Foxton
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director82131150001
    POLLARD, David
    Merrymickle
    Burney Road
    RH5 6AU Westhumble
    Surrey
    পরিচালক
    Merrymickle
    Burney Road
    RH5 6AU Westhumble
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director77584370001
    ROWLAND, John Philip
    Sefton Lodge
    Rough Road
    GU22 0RB Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Sefton Lodge
    Rough Road
    GU22 0RB Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director66445820001

    TELE-CINE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 48 charlotte street london t/n 254983. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 50/54 charlotte street l/b of camden t/no: LN136472. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property part of 61/63 charlotte street london W1 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts and the benefit of any licences a specific equitable charge over all f/hold or l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All stocks shares & other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0