NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNM LIFE RESIDENTIAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01530074
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GE LIFE RESIDENTIAL LIMITED১৮ অক্টো, ১৯৯৯১৮ অক্টো, ১৯৯৯
    STALWART RESIDENTIAL LIMITED২২ নভে, ১৯৯৪২২ নভে, ১৯৯৪

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    ২২ আগ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB থেকে 30 Finsbury Square London EC2P 2YUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Windsor House Telford Centre Telford TF3 4NB এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ মে, ২০১৪

    ২৯ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 721,874
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    25 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Auth to allot shares & duty to avoid conflicts of interest 24/06/2013
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Minimum number of directors is one 24/06/2013
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    5 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    5 পৃষ্ঠাMR04

    ০৪ অক্টো, ২০১০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Roger Craine এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ অক্টো, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael Charles Woodcock-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০৭ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Roger Craine-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHAKESPEARE, Paul
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    সচিব
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    পরিচালক
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish102653720001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    সচিব
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    British150997870001
    CHAMBERS, Mark Richard
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    সচিব
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    British69321020002
    DUGGAN, Helen
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    সচিব
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    British67744330001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    সচিব
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    HARDING, Barrington Howard
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    সচিব
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    British11466730001
    OPPAL, Abdul Munem
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    সচিব
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    British116338770001
    PEARSON, Michael Adrian
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    সচিব
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    British59751140001
    TEMPLETON, William James, Dr
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    সচিব
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    New Zealander27024160001
    THOMAS, Derek John
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    সচিব
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British2297010001
    WELCH, Gaynor Jill
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    সচিব
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    British87931760001
    ARTHUR, Richard
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    পরিচালক
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    British71058650001
    BARRETT, Peter
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    পরিচালক
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    British75515090001
    BARTLETT, John Leonard
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    পরিচালক
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    British14120450001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish150997870001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    পরিচালক
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritish106900580001
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    পরিচালক
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrish63716360005
    COWDERY, Clive Adam
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    পরিচালক
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    British88183990001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    পরিচালক
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritish89585440001
    DAVIES, Roger William
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    পরিচালক
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    British21933520001
    DICKINSON, Stephen
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    British14120430001
    DOLFI, Douglas Scott
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    পরিচালক
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    American78292660001
    DOWNEY, Paul Martin
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    British10360260002
    EVANS, David Thomas James
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    পরিচালক
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish62761080001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    পরিচালক
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    GIRLING, Michael
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    British63304110001
    HAMMOND, Anthony
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    পরিচালক
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    British52752380001
    HAYNES, Stephen Robert
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    পরিচালক
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish79961770002
    HOWE, Robert William Albert
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    পরিচালক
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkBritish13105310003
    HUGHFF, Victor William
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    পরিচালক
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    British6622110001
    MCLAY, William Morrison
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    পরিচালক
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    British54996780001
    MORGAN, Christopher
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    পরিচালক
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    United KingdomBritish33875890001
    NARRAWAY, Nicholas William
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    British72113010001
    RAAB, Dennis Lynn
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    American48186120003

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 24TH march 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 5 wantage road, reading berkshire; f/h property k/a 3 wantage road, reading, berkshire t/nos: BK274399 and BK26127 floating charge over the whole of the company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (including this debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2 richard avenue brightlingsea essex including fixtures and fittings and f/h or l/h property all right title & interest in the real property the benefit of all rights and claims the insurance policies all book & other debts and a floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 3 madeley drive west kirby wirral merseyside t/no MS155589 with all fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the finance documents (including this debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    8 wellesley court west parade worthing t/n-WSX26301. Flat 3 castle court river park marlborough wiltshire west kennett t/n-WT101180. Gathorne 24 walmers avenue higham nr rochester kent t/n-K133345.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company as beneficial owner hereby charges by fixed charge in favour of the trustee with the payment and discharge of the secured obligations by way of (a) first legal mortgage over the real property; and (b) first equitable charge over its right title and interest in the real property. And by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future other than any assets for the time being effectively charged to the trustee by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৬ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security account agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the companys interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence od the security account agreement standing to the credit of (a) the security account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the security account agreement.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Faciltiy Agreement))
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Collection account agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence of the collection account agreement standing to the credit of (a) the collection account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the collection account agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including & goodwill bookdebts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৮ আগ, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৬ ডিসে, ২০১৪ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0