AF REALISATIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামAF REALISATIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01531702
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    AF REALISATIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ফাস্টেনার এবং স্ক্রু মেশিন পণ্য উত্পাদন (25940) / উৎপাদন
    • অন্যান্য প্রস্তুতকৃত ধাতব পণ্য উত্পাদন (25990) / উৎপাদন
    • হার্ডওয়্যার, প্লাম্বিং এবং গরম সরঞ্জাম এবং সরবরাহের পাইকারি ব্যবসা (46740) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    AF REALISATIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Moorend House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    AF REALISATIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ANDREWS FASTENERS LIMITED০৭ নভে, ১৯৮৩০৭ নভে, ১৯৮৩
    ANDREWS TOOLS AND FASTENERS (LEEDS) LTD৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১
    DAYAWAY LIMITED০২ ডিসে, ১৯৮০০২ ডিসে, ১৯৮০

    AF REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    AF REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    25 পৃষ্ঠাLIQ14

    আদালতের আদেশ দ্বারা লিকুইডেটর অপসারণ

    8 পৃষ্ঠাLIQ10

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    ০৯ আগ, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    26 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৯ আগ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    25 পৃষ্ঠাLIQ03

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    15 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    15 পৃষ্ঠাAM22

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Joanne Denham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ১৫ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৫ জুল, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৫ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১৫ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    16 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    33 পৃষ্ঠা2.23B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    8 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    32 পৃষ্ঠা2.17B

    ২৮ জানু, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Unit 8 Latchmore Park Latchmore Road Leeds Yorkshire LS12 6DN থেকে Moorend House Snelsins Lane Cleckheaton BD19 3UEপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed andrews fasteners LIMITED\certificate issued on 19/01/15
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৯ জানু, ২০১৫

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৬ জানু, ২০১৫

    RES15

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 10 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    AF REALISATIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CAREY, Michael Robson
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Moorend House
    পরিচালক
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Moorend House
    EnglandBritish110593220002
    CONNER, Eileen
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    সচিব
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    British89546940001
    DENHAM, Joanne
    Camberley Way
    Pudsey
    LS28 8QX Leeds
    19
    West Yorkshire
    সচিব
    Camberley Way
    Pudsey
    LS28 8QX Leeds
    19
    West Yorkshire
    British188654670001
    HAGUE, David Michael
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    সচিব
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    British45671950001
    HALL, Robert John
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    সচিব
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    British76827960001
    KRAUSE, Patricia
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    সচিব
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    British88921990001
    LAWTON, Kirsten
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    সচিব
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    British50045660001
    RIDGEWAY, Kevin Stuart
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    সচিব
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    British73705320001
    SANDERSON, Gary
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    সচিব
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    British19581810003
    SPEDDING, Gary James
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    সচিব
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    British76827940001
    BATTENSBY, Mark
    36 Valley Road
    Bramley
    LS13 1EZ Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    36 Valley Road
    Bramley
    LS13 1EZ Leeds
    West Yorkshire
    British76827890001
    BUDD, Jonathan William
    1 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    1 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    British14530230001
    GEARTY, Anthony John
    Long Acres
    Poole Lane
    LS25 5JU Burton Salmon
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Poole Lane
    LS25 5JU Burton Salmon
    West Yorkshire
    EnglandIrish127463800002
    GRINDY, Roger Sydney
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British8369140001
    HAGUE, David Michael
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    পরিচালক
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    British45671950001
    HALL, Robert John
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish76827960001
    KRAUSE, Patricia
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    পরিচালক
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    United KingdomBritish88921990001
    LOVERIDGE, Keith
    4 Swannington Close
    Whitehill Cantley
    DN4 6UA Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    4 Swannington Close
    Whitehill Cantley
    DN4 6UA Doncaster
    South Yorkshire
    British76827920001
    MCINNES, Bruce Gordon, Doctor
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    পরিচালক
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    British2311870001
    PANTRY, Malcolm Swaine
    33 Berwick Close
    Walton
    S40 3NY Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    33 Berwick Close
    Walton
    S40 3NY Chesterfield
    Derbyshire
    British37363480001
    PERKINS, John Anthony
    Elangeni
    20 Esher Place Avenue
    KT10 8PY Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Elangeni
    20 Esher Place Avenue
    KT10 8PY Esher
    Surrey
    Irish1809090001
    SANDERSON, Gary
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    British19581810003
    SMITH, David Dallas
    44 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QJ London
    পরিচালক
    44 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QJ London
    British36289330001
    SPEDDING, Gary James
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    পরিচালক
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    British76827940001
    SURR, Robin
    Manor Road
    S60 5HF Brinsworth
    12
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Manor Road
    S60 5HF Brinsworth
    12
    South Yorkshire
    EnglandBritish133505110001
    WILKINSON, Stephen Philip
    8 Norton Mews
    Norton
    S8 8HN Sheffield
    পরিচালক
    8 Norton Mews
    Norton
    S8 8HN Sheffield
    EnglandBritish35390660002
    BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    50433100001
    COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    43767230002

    AF REALISATIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০১৫
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Lease
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £17,331.25 including a sum equal to vat. The amount from time to time held in the deposit account for the credit of the tenant ("the deposit balance"). The amount from time to time standing to the credit of the deposit balance. All interest credited to the deposit balance from time to time.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial Property Investment Fund
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from andrews fasteners limited and andfast trading company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb re andrews fasteners limited and numbered 6311907 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০১৪সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    • ১৬ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the financing agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of andrews fasteners limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balances at credit of any accounts held by the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Govenor and Company of the Bank of Scotland.
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of andrews fasteners limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £164,744 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. Fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ralin Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £16,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. Uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ralin Holdings PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    AF REALISATIONS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ জানু, ২০১৫প্রশাসন শুরু
    ১০ আগ, ২০১৭প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Christopher Brooksbank
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    অভ্যাসকারী
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    2
    তারিখপ্রকার
    ১০ আগ, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৮ সেপ, ২০২১ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Christopher Brooksbank
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    অভ্যাসকারী
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Jeremy Michael Bennett
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0