BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01571833
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TROLHURST LIMITED০১ জুল, ১৯৮১০১ জুল, ১৯৮১

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৯ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৯ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার - পূর্বে সদস্যদের স্বেচ্ছায় দ্রবীভূতকরণে

    2 পৃষ্ঠাREST-MVL

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew William Hodges-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicola Margaret Carroll এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 10 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ ফেব, ২০১৬

    ০৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ০৯ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Nicola Margaret Carroll-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ ফেব, ২০১৫

    ১৭ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ ফেব, ২০১৪

    ২৭ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Steven Buck এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Centrica Directors Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    পরিচালক হিসাবে Nicola Margaret Carroll-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Matthew Bateman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    কর্পোরেট সচিব
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    71532760003
    HODGES, Andrew William
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish77527910004
    CENTRICA DIRECTORS LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর3844287
    146695600001
    FREUDMANN, Anthony
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    সচিব
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    British43335320001
    WHEATLEY, Trevor Neil Pearse
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    সচিব
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    British34588420002
    ARIF, Louise
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    পরিচালক
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    British36425190002
    BASSIS, Anne Elizabeth
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    পরিচালক
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    United KingdomAmerican/British112345920001
    BATEMAN, Matthew James
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish138280510002
    BOWTELL, John Paul Maurice
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    পরিচালক
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    British82969690001
    BUCK, Steven John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish96292880001
    CARROLL, Nicola
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish278861170001
    COLLIER, Edward Arthur Yarlet
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    British72213650001
    CORBETT, Michael Anthony
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    পরিচালক
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    British7008160003
    CORDINGLEY, Anthony Clive
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    পরিচালক
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    British7008170001
    DUNN, David Young
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    পরিচালক
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    British38982880001
    FARRAR, John Trueman
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    British34540860001
    FARROW, Dennis
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    পরিচালক
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    British10910860001
    FLETT, Alan Douglas
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    পরিচালক
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish93037840001
    HAYWARD, Ian Charles
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    British79564240001
    KENDLE, David Philip
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish95977510001
    KENYON, Rodney Frank
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    পরিচালক
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    EnglandBritish62258710001
    LAIRD, James
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    পরিচালক
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    British34535330001
    LENHAM, Stephen
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    British7008190004
    MAXEY, Clement Leslie
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    British37195980001
    PINCHIN, Terence Rodney
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    পরিচালক
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    British65159820001
    RAY, John Albert
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    পরিচালক
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish104536620001
    SHAW, Daniel Rankin
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    পরিচালক
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    ScotlandBritish7008210001
    SHEARS, John Nicholas
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    BritishBritish61771310001
    STERN, Christopher John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    EnglandEnglish55825790001
    TURNER, Moira Lynne
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82549950002
    UZIELLI, Michael Robin
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    British107591700002

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H 320C mayoral way team valley trading estate gateshead tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold - 24 hampton court king and queen wharf rotherhithe st,london SE16. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property at unit 10 bessemer park herne hill london (leasehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property at 239 milkwood road herne hill london (freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date between the landlord and the tenant relating to unit B7 the avenues team valley gateshead
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the compamy's right title and interest in and to the rent deposit sum of £1,365 an all related rights thereto and thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Renbrook Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the rent deposit deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rent deposit of £1300.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Renbrook Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property at 11 lindsay square london (leasehold) with the benefit of all rights licences guarantees and rent deposits with the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed equitable charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Griffin Factors Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £225,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property- 11 lindsay sq,millbank,london SW1.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Slark Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a unit 12 bessemer park milkwood road herne hill london with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/as units 22 & 23 bessemer park milkwood road herne hill london SE24 ohh. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 18/01/82
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital patents/applications and trade marks etc. (for full details see form 395 tc ref: M331C).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    115 marsham court marsham street london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জানু, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book and other debts now and from time to time due floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জানু, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৯ এপ্রি, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0