HELITECH (LUTON) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHELITECH (LUTON) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01585230
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HELITECH (LUTON) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    HELITECH (LUTON) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Cabair Building 1 Cranfield Airfield
    Wharley End, Cranfield
    MK43 0JR Bedford
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HELITECH (LUTON) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRENT-HELITECH LIMITED১০ সেপ, ১৯৮১১০ সেপ, ১৯৮১
    WAGTAIL MOTORS LIMITED১০ সেপ, ১৯৮১১০ সেপ, ১৯৮১

    HELITECH (LUTON) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১০

    HELITECH (LUTON) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Christopher Leigh এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    পরিচালক হিসাবে Mr Christopher Michael Leigh-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Spencer Cruise-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Stephen Read এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ জানু, ২০১১

    ২৮ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে James Hunter Smart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে James Hunter Smart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr James Edward Hunter Smart-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Mr James Edward Hunter Smart-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Michael Bradly Russell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Michael Russell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    HELITECH (LUTON) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CRUISE, Andrew Spencer
    Cranfield Airfield
    Wharley End, Cranfield
    MK43 0JR Bedford
    Cabair Building 1
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cranfield Airfield
    Wharley End, Cranfield
    MK43 0JR Bedford
    Cabair Building 1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector116991450001
    BELCHER, Mary Frances
    51 Bury Road
    Shillington
    SG5 3NY Hitchin
    Hertfordshire
    সচিব
    51 Bury Road
    Shillington
    SG5 3NY Hitchin
    Hertfordshire
    British73147940001
    BRADLY RUSSELL, Michael John
    Lomg
    Close, Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Hertfordshire
    সচিব
    Lomg
    Close, Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant118662260002
    COATES, Lorna
    129 Stanford Road
    LU2 0PZ Luton
    Bedfordshire
    সচিব
    129 Stanford Road
    LU2 0PZ Luton
    Bedfordshire
    British9145960001
    HUNTER SMART, James Edward
    The Cabair Building
    Elstree Aerodrome
    WD6 3AW Borehamwood
    Hertfordshire
    সচিব
    The Cabair Building
    Elstree Aerodrome
    WD6 3AW Borehamwood
    Hertfordshire
    152572790001
    READ, Stephen John
    The Garth
    Welders Lane
    SL9 8TU Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    সচিব
    The Garth
    Welders Lane
    SL9 8TU Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishDirector2897330003
    READ, Stephen John
    The Garth
    Welders Lane
    SL9 8TU Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    সচিব
    The Garth
    Welders Lane
    SL9 8TU Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British2897330003
    COATES, Graham Victor Frederick
    129 Stanford Road
    LU2 0PZ Luton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    129 Stanford Road
    LU2 0PZ Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishAircraft Engineer4755210001
    HEATHCOTE, Edgar Colin
    Greenend Barn
    Datchworth Green Datchworth
    SG3 6TL Knebworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Greenend Barn
    Datchworth Green Datchworth
    SG3 6TL Knebworth
    Hertfordshire
    BritishManaging Director11234240001
    HENRY, Maurice Charles
    11 Clonard Way
    HA5 4BT Hatch End
    Middlesex
    পরিচালক
    11 Clonard Way
    HA5 4BT Hatch End
    Middlesex
    EnglandBritishDirector91857380001
    HUNTER SMART, James Edward
    House
    Ford
    SP4 6DX Salisbury
    Castleford Farm
    Wiltshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    House
    Ford
    SP4 6DX Salisbury
    Castleford Farm
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant18240120003
    LEIGH, Christopher Michael
    Cranfield Airfield
    Wharley End, Cranfield
    MK43 0JR Bedford
    Cabair Building 1
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cranfield Airfield
    Wharley End, Cranfield
    MK43 0JR Bedford
    Cabair Building 1
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant24955980002
    READ, Stephen John
    Landmark 14 Seacombe Road
    Sandbanks
    BH13 7RJ Poole
    Flat 8
    Dorset
    United Kingdom
    পরিচালক
    Landmark 14 Seacombe Road
    Sandbanks
    BH13 7RJ Poole
    Flat 8
    Dorset
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector2897330004
    RUSSELL, Michael John Bradly
    Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Long Close
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Long Close
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant137277160001

    HELITECH (LUTON) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of aircraft
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £30,500 on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Bell helicopter, bell 47 helicopter serial no. 7952 reg. Mark co-bgiv and store of spare parts appropriated thereto together with all passenger fares cargo freights charter monies compensation remuneration demurrage detention monies and other monies whatsoever to be earned by the aircraft and all policies of insurance taken out in respect of the aircraft her freights disbursements or otherwise howsoever and all the benefits thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £25,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Bell 47-G5 helicopter engine serial no L3270-31 serial no 7864 reg. Mark g bldf & store of spare parts see doc M14 for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H hanger 56 luton airport luton bedfordshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0