TELEFLEX UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTELEFLEX UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01600496
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TELEFLEX UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    TELEFLEX UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Teleflex Medical Uk
    Stirling Road
    HP12 3ST Cressex Business Park
    High Wycombe
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TELEFLEX UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    IMO INDUSTRIES (UK) LIMITED২২ ডিসে, ১৯৮৯২২ ডিসে, ১৯৮৯
    BAIRD U.K. HOLDINGS LIMITED১৭ মার্চ, ১৯৮২১৭ মার্চ, ১৯৮২
    TOUCHVALE LIMITED২৭ নভে, ১৯৮১২৭ নভে, ১৯৮১

    TELEFLEX UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    TELEFLEX UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ১৯ অক্টো, ২০০৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    1 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share prem a/c
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    TELEFLEX UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    সচিব
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Irish127397580001
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    পরিচালক
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish127397580001
    WILLIAMS, Charles Edward
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    পরিচালক
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    United StatesAmerican122869170001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    সচিব
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    সচিব
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    British116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    সচিব
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    সচিব
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    HARRISON, Brian
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    সচিব
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    British13648350001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    সচিব
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    British62562220002
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    সচিব
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    French122049100001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    সচিব
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    British71945940002
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    সচিব
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    British103274200001
    STREETER, Andrew Charles
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    সচিব
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    British69339090001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    পরিচালক
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    পরিচালক
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    British116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    পরিচালক
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    British76507470001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    British76507470001
    BRADLEY, George Edward William
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    পরিচালক
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    American76157540001
    BUSHELL, Anthony Thomas
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    British69190050001
    CARROLL, Leffert
    588 Conroy Avenue
    Toms River
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    পরিচালক
    588 Conroy Avenue
    Toms River
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    American18905150001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    পরিচালক
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    DAWSON-GOODEY, Andrew John
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    British56963660001
    DERR LL, Robert
    23
    Independence Way
    08560 Titusville
    New Jersey
    Usa
    পরিচালক
    23
    Independence Way
    08560 Titusville
    New Jersey
    Usa
    Usa47901970001
    GILL, John George
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    British58095740001
    GREEN, Raymond Charles
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    পরিচালক
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    British27243660001
    HALL, Allan Robert Macalister
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    পরিচালক
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    British68216820001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    British62562220002
    KING, Ian Robert
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    EnglandBritish103274150002
    LAW, Michael Barry
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    পরিচালক
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    British95044260001
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    পরিচালক
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    French122049100001
    LEWIS, Brian
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    পরিচালক
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    British18905160001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    পরিচালক
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritish71945940002
    MCCANN, Terence Michael Paul
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    British61786230001
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    পরিচালক
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    British103274200001

    TELEFLEX UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Equitable share charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement or any other loan document (as defined) and all of the obligations (as defined in the credit agreement) under the credit agreement and the other loan documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) 2678,576 shares of £1 each in the capital of imo industries limited and (ii) 683,234 £1 shares each and 733,280 deferred £1 shares in the capital of morse controls limited; all other dividends/other income payable and all shares/other property from securities; all other rights,benefits,etc. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Usa,Inc.
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable share charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities now or hereafter due from the borrower (as defined) to the chargee under or pursuant to the credit agreement dated 5TH august 1994 (as defined) and any other loan document (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All securities,dividends and other income payable; all shares or other property; all other rights,benefits......etc.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank,N.a,as Agent for Itself,the Lenders and the Issuing Banks
    ব্যবসায়
    • ২৮ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুন, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৬ মে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0