UNICARE SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামUNICARE SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01601618
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    UNICARE SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    UNICARE SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    UNICARE SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INDIGO SELECTION LIMITED০৩ নভে, ২০০০০৩ নভে, ২০০০
    ABACUS RECRUITMENT PLC২১ জুল, ১৯৮৮২১ জুল, ১৯৮৮
    WARRION LIMITED০৩ ডিসে, ১৯৮১০৩ ডিসে, ১৯৮১

    UNICARE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ ডিসে, ২০১১

    UNICARE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ সেপ, ২০১১

    ০৫ সেপ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 78,604.8
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Andrew Burchall-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Rebecca Jane Watson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Rebecca Jane Watson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    UNICARE SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor70686070002
    FIRMANSJAH, Tony
    106 Grenville Court
    Ham View Shirley
    CR0 7XB Croydon
    Surrey
    সচিব
    106 Grenville Court
    Ham View Shirley
    CR0 7XB Croydon
    Surrey
    Indonesian13648600001
    HYMAN, Martin Barry
    11d Selborne Road
    Southgate
    N14 7DD London
    সচিব
    11d Selborne Road
    Southgate
    N14 7DD London
    British69202570001
    OSBORNE, Philip Thomas
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    সচিব
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    British76955710002
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    সচিব
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    BritishCompany Secretary38346120001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    সচিব
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    RAWES, George Romney
    Primrose Cottage
    New Farm Road
    SO24 9QH Alresford
    Hampshire
    সচিব
    Primrose Cottage
    New Farm Road
    SO24 9QH Alresford
    Hampshire
    BritishAccountant45863960001
    RAWES, George Romney
    Primrose Cottage
    New Farm Road
    SO24 9QH Alresford
    Hampshire
    সচিব
    Primrose Cottage
    New Farm Road
    SO24 9QH Alresford
    Hampshire
    BritishAccountant45863960001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    সচিব
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    British57975730001
    ASHWORTH, Gary Peter
    151 Ebury Street
    SW1W 9QN London
    পরিচালক
    151 Ebury Street
    SW1W 9QN London
    BritishCompany Director39779300001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    পরিচালক
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritishManaging Director72452740004
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director58806030001
    DONNISON, Adam Clive
    Tumblewood
    Rickman Hill Road
    CR5 3LD Chipstead
    Surrey
    পরিচালক
    Tumblewood
    Rickman Hill Road
    CR5 3LD Chipstead
    Surrey
    BritishCompany Director56119790002
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    পরিচালক
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritishDirector266121440001
    FIRMANSJAH, Tony
    106 Grenville Court
    Ham View Shirley
    CR0 7XB Croydon
    Surrey
    পরিচালক
    106 Grenville Court
    Ham View Shirley
    CR0 7XB Croydon
    Surrey
    IndonesianFinance Director13648600001
    FOUND, Alan William
    Brynffynon
    Cynwd
    W11 0LG Corwen
    Clwyd
    পরিচালক
    Brynffynon
    Cynwd
    W11 0LG Corwen
    Clwyd
    BritishManagement Trainer47970310001
    HILL, Clive John
    53 Westgate
    Nafferton
    YO25 0LJ Driffield
    North Humberside
    পরিচালক
    53 Westgate
    Nafferton
    YO25 0LJ Driffield
    North Humberside
    BritishDirector66760020001
    HYMAN, Martin Barry
    11d Selborne Road
    Southgate
    N14 7DD London
    পরিচালক
    11d Selborne Road
    Southgate
    N14 7DD London
    BritishChartered Accountant69202570001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    পরিচালক
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    BritishCompany Director56699270001
    KING, Marcus Stuart
    81 The Fairway
    Oakwood
    N14 4PB London
    পরিচালক
    81 The Fairway
    Oakwood
    N14 4PB London
    EnglandBritishFinance Director120265130001
    MCDONNELL, Sally
    9 Vanborough Court
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    পরিচালক
    9 Vanborough Court
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    BritishOperations Director13648590001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary38346120001
    RAWES, George Romney
    Primrose Cottage
    New Farm Road
    SO24 9QH Alresford
    Hampshire
    পরিচালক
    Primrose Cottage
    New Farm Road
    SO24 9QH Alresford
    Hampshire
    BritishChartered Accountant45863960001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    পরিচালক
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant57975730001
    WILKINSON, Sarah
    Flat 3 123a Ifield Road
    Chelsea
    SW10 9AR London
    পরিচালক
    Flat 3 123a Ifield Road
    Chelsea
    SW10 9AR London
    BritishChartered Accountant53548710001
    SOUTHTOWN LIMITED
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    70598540001

    UNICARE SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of floating charge between the chargors (as defined), the bank of nova scotia as agent and security trustee (the security trustee) for the secured parties (as defined), tracedance limited and capital group limited as security trustee for the secured parties
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All liabilities of the chargors to the security trustee under or in respect of the credit agreement, the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each chargor under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the shares defined on the form 395 and all other charged shares all other charged property and all dividends distributions interest and other payments an d rights and all proceeds of the foregoing.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of Nova Scotia
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge and memorandum of deposit between the depositors (as defined) and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the security trustee) for the lenders (as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations of the depositors to the security trustee under or in respect of the credit agreement, the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each depositor under the charge and memorandum
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the shares defined on the form 395 and all other charged shares all other charged property and all dividends distributions interest and other payments and rights and all proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of Nova Scotia
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed equitable charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed equitable charge over all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Griffin Factors Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ ডিসে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0