JACQUES VERT (RETAIL) LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJACQUES VERT (RETAIL) LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01604388
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    32-38 Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JUELLA (FASHIONS) LIMITED১৫ ডিসে, ১৯৮১১৫ ডিসে, ১৯৮১

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জানু, ২০১৬

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০১ নভে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ১৯ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ মে, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 46 Colebrooke Row London N1 8AF থেকে 32-38 Scrutton Street London EC2A 4RQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    ০৮ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tim Morgan Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ নভে, ২০১৫

    ০৬ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    চার্জ নিবন্ধন 016043880007, ২৪ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    40 পৃষ্ঠাMR01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Teresa Tideman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Tim Davies-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Shaun Simon Wills-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Clare Bennett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৫ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ অক্টো, ২০১৪

    ২৪ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Joanne Clare Bennett-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ian Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ নভে, ২০১৩

    ১৫ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৬ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mrs Amanda Claire Fogg-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Philip Watt এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FOGG, Amanda Claire
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    সচিব
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    181380680001
    WILLS, Shaun Simon
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    পরিচালক
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer185717270001
    ALLEN, Paul Christopher
    Wescott, 8 Beacon Rise
    TN13 2NJ Sevenoaks
    Kent
    সচিব
    Wescott, 8 Beacon Rise
    TN13 2NJ Sevenoaks
    Kent
    Irish54253320002
    BRYAN, Paul Anthony Edward Peter
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    সচিব
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    BritishCompany Secretary25267050001
    CASH, Daphne Valerie
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    সচিব
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary59646330005
    HEARD, Nicholas James
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    সচিব
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    BritishCompany Secretary132971860003
    JOHNSON, Ian Paul
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    সচিব
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    British76187110001
    MYLVAGAHAM, Sagitharan
    9 Ashwell Avenue
    GU15 2AR Camberley
    Surrey
    সচিব
    9 Ashwell Avenue
    GU15 2AR Camberley
    Surrey
    British17075960001
    WARBURTON, Jenny
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    সচিব
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    156827610001
    WATT, Philip Graham
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    সচিব
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    163920930001
    WILLIAMS, Denise
    38 Lynton Road South
    DA11 7NF Gravesend
    Kent
    সচিব
    38 Lynton Road South
    DA11 7NF Gravesend
    Kent
    British24311940001
    ALLEN, Paul Christopher
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomIrishDirector185112730001
    ASHFORTH, Phillip John
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    পরিচালক
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director1311000004
    BELL, Frank Charles
    8 Coltsfoot Road
    Lindford
    GU35 0YS Bordon
    Hampshire
    পরিচালক
    8 Coltsfoot Road
    Lindford
    GU35 0YS Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritishRetailer15396430001
    BENNETT, Joanne Clare
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishChief Finance Officer184759270001
    BRYAN, Paul Anthony Edward Peter
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    পরিচালক
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    BritishCompany Secretary25267050001
    CASH, Daphne Valerie
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary59646330005
    CYNAMON, Jack
    Boundaries House 106 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NX Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Boundaries House 106 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NX Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director142370750001
    DAVIES, Tim Morgan
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomBritishRetail Director197113400001
    GREEN, Alan Michael
    Threshers
    Threshersbush
    CM17 0NP Harlow
    Essex
    পরিচালক
    Threshers
    Threshersbush
    CM17 0NP Harlow
    Essex
    BritishCompany Director94836450001
    HEALD, Malcolm Barclay
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant1605080001
    HEILBRON, Brian
    6 Nafferton Rise
    IG10 1UB Loughton
    Essex
    পরিচালক
    6 Nafferton Rise
    IG10 1UB Loughton
    Essex
    EnglandBritishCompany Director102947240001
    JOHNSON, Ian Paul
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomBritishFinance Director76187110001
    LLEWELLYN, William Geoffrey
    Garden Lodge 3 Larkhall Rise
    Clapham
    SW4 6JB London
    পরিচালক
    Garden Lodge 3 Larkhall Rise
    Clapham
    SW4 6JB London
    BritishRetail Operations35176730001
    MONTGOMERY, Antony Peter
    6 Greencroft
    GU1 2SY Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    6 Greencroft
    GU1 2SY Guildford
    Surrey
    BritishDirector55319870001
    MORRIS, Sarah
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishDirector174804590001
    MYLVAGAHAM, Sagitharan
    9 Ashwell Avenue
    GU15 2AR Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    9 Ashwell Avenue
    GU15 2AR Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant17075960001
    REID, William
    Baykers
    Lamb Lane, Sible Hedingham
    CO9 3RS Halstead
    Essex
    পরিচালক
    Baykers
    Lamb Lane, Sible Hedingham
    CO9 3RS Halstead
    Essex
    BritishDirector66677420001
    TIDEMAN, Teresa Mary
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishCompany Director150161210001
    TIEDMAN, David Arthur
    26 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    পরিচালক
    26 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    BritishManaging Director17080540001

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Style Group Brands Limited
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Liability Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানThe Registrar Of Companies For England & Wales
    নিবন্ধন নম্বর1075752
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    JACQUES VERT (RETAIL) LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০১৫
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jacques Vert Holdings S.a R.L.
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Guarantee and fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due by any chargor to a lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Present real property, future real property, other assets, book debts, bank accounts, investments, uncalled capital and goodwill, plant and machinery, insurances and all related proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of Hsbc Bank PLC and Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref. M240C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0