ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01624055
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CDS GROUP LTD.১৭ এপ্রি, ১৯৯৭১৭ এপ্রি, ১৯৯৭
    CLINICAL DATA SYSTEMS GROUP LTD ২০ ডিসে, ১৯৯৪২০ ডিসে, ১৯৯৪
    CLINICAL DATA SYSTEMS LIMITED২৩ মার্চ, ১৯৮২২৩ মার্চ, ১৯৮২

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১২

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে David William Hart Gray-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Gareth Antony Wilson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ মার্চ, ২০১৩

    ০১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,440.39
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adrian Charles Stevens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    2 পৃষ্ঠাMG02

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ জুন, ২০১২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Adrian Charles Stevens-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Andrea Fiumicelli-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Andrew James Edward Thomson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Gareth Antony Wilson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    সচিব হিসাবে Mr Gareth Antony Wilson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew James Edward Thomson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে James Mackay এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Howard Edelman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    সচিব
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177358100001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    ALTON, Richard
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    সচিব
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    British26776810002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    সচিব
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    সচিব
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    WAINWRIGHT, Philip Eric
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    সচিব
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    British26620230001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    সচিব
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    সচিব
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    BritishDirector69575560002
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    সচিব
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162049080001
    ALLEN, Christine Florence
    1 Bargate Close
    Bargate
    DE56 0TL Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    1 Bargate Close
    Bargate
    DE56 0TL Belper
    Derbyshire
    BritishAdministrator26620250001
    ALLEN, David John
    Quarry Bungalow Duffield Bank
    Duffield
    DE56 4BG Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    Quarry Bungalow Duffield Bank
    Duffield
    DE56 4BG Belper
    Derbyshire
    BritishManaging Director37312230002
    ALTON, Richard
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    BritishChartered Accountant26776810002
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    পরিচালক
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    পরিচালক
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    EnglandBritishDirector58894020001
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector63562150001
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishOperations Director45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    পরিচালক
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    GREEN, Patricia Gale
    Valley View Cross O The Hands
    Turnditch
    DE56 2LT Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    Valley View Cross O The Hands
    Turnditch
    DE56 2LT Belper
    Derbyshire
    BritishSales Director26620270001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    LODGE, Robin Wilfred Ian
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    পরিচালক
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director154369990002
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinancial Director178097680001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    পরিচালক
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    VINCENT, David
    38 Primley Park Avenue
    Alwoodley
    LS17 7HU Leeds
    পরিচালক
    38 Primley Park Avenue
    Alwoodley
    LS17 7HU Leeds
    BritishChief Executive Officer45459550001
    WAINWRIGHT, Philip Eric
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    BritishChief Accountant & Secretary26620230001
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    পরিচালক
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishFinance Director105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WILKINSON, Martin
    5 Primrose Drive
    OX26 3WP Bicester
    Oxfordshire
    পরিচালক
    5 Primrose Drive
    OX26 3WP Bicester
    Oxfordshire
    BritishDevelopment Director74264310001

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৩ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০১ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge over the managed service agreement between isoft laboratory systems limited and western health board dated 29/4/02 and the equipment and software being the subject of the managed service agreement.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ba/Ca Asset Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under (I) an overdraft letter dated 5 february 2001, (ii) any letter or agreement amending,replacing,varying or extending the facilities available under the overdraft letter and (iii) any letter or agreement providing working capital or other ancillary facilities to the company; and all other money and liabilities expressed to be secured under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital. With all trade and other fixtures and fittings, fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0