INTER-CITY PAGING LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামINTER-CITY PAGING LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01643672
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ওয়্যারলেস টেলিকমিউনিকেশন কার্যক্রম (61200) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    INTER-CITY PAGING LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    C.I. RADIOPAGING LIMITED২৪ আগ, ১৯৮২২৪ আগ, ১৯৮২
    ANVILBEACON LIMITED১৬ জুন, ১৯৮২১৬ জুন, ১৯৮২

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 17 Rochester Row London SW1P 1QT থেকে 1 More London Place London SE1 2AFপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 71 Victoria Street London SW1H 0XA এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 71 Victoria Street London SW1H 0XA এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    ০৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Francesca Anne Todd-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher Francis Henry Baker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stefan John Maynard এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২৮ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে William Stephen Mcbrinn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Christopher Francis Henry Baker-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Craig Hilton Rodgerson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr William Stephen Mcbrinn-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jamie Leigh Radford এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ এপ্রি, ২০১৬

    ১৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Jamie Leigh Radford-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael Patrick Collier এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ জুল, ২০১৫

    ২১ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    পরিচালক
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish72249980002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর5641516
    129795770003
    ATHERSYCH, Christopher John
    Greenwood St Olives Close
    Cross In Hand
    TN21 0QE Heathfield
    East Sussex
    সচিব
    Greenwood St Olives Close
    Cross In Hand
    TN21 0QE Heathfield
    East Sussex
    British78115670001
    CHADWICK, Alan Michael
    96 Warwick Avenue
    HA8 8UJ Edgware
    Middlesex
    সচিব
    96 Warwick Avenue
    HA8 8UJ Edgware
    Middlesex
    British16262350001
    DICKINSON, Peter John Goddard
    39 Park Road
    TW11 0AY Teddington
    Middlesex
    সচিব
    39 Park Road
    TW11 0AY Teddington
    Middlesex
    British38889200001
    LYELL, Stephen Edward
    39 Egham Road
    Plaistow
    E13 8PD London
    সচিব
    39 Egham Road
    Plaistow
    E13 8PD London
    British61928420001
    MEDCALF, Sarah
    Marsh Lane
    Taplow
    SL6 0DE Maidenhead
    Glengarry
    England
    সচিব
    Marsh Lane
    Taplow
    SL6 0DE Maidenhead
    Glengarry
    England
    159244830001
    SIMON, Hugh Adams, Mr.
    Chilton Lodge Speen Lane
    RG14 1RN Newbury
    Berkshire
    সচিব
    Chilton Lodge Speen Lane
    RG14 1RN Newbury
    Berkshire
    British49056950001
    TAYLOR, Michael John
    109 Hallowell Road
    HA6 1DY Northwood
    Middlesex
    সচিব
    109 Hallowell Road
    HA6 1DY Northwood
    Middlesex
    British75861690001
    ATTWOOLL, Rodney Philip
    18 Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    18 Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    Berkshire
    British63982200002
    BAKER, Christopher Francis Henry
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish219844020001
    BOTTS, John Chester
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    পরিচালক
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    United KingdomAmerican2943960001
    COLLIER, Michael Patrick
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish182710350001
    D'JANOEFF, Alexander Constantine Basil
    Flat 3 Avenue Court
    Draycott Avenue
    SW3 3BU London
    পরিচালক
    Flat 3 Avenue Court
    Draycott Avenue
    SW3 3BU London
    British69177260001
    FRAWLEY, Michael
    36 Ampthill Road
    Silsoe
    MK45 4DX Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    36 Ampthill Road
    Silsoe
    MK45 4DX Bedford
    Bedfordshire
    British70921480001
    FUELLHART, Janice
    14 Grosvenor Hill Court
    15 Bourdon Street
    W1K 3PX London
    পরিচালক
    14 Grosvenor Hill Court
    15 Bourdon Street
    W1K 3PX London
    Us Citizen49542950007
    FUGATE, John Robert
    1633 Winchester
    MS 39211 Jackson
    Mississippi
    Usa
    পরিচালক
    1633 Winchester
    MS 39211 Jackson
    Mississippi
    Usa
    American16262360004
    GOOD, Alexander Hansen
    23 Eastbrooke
    FOREIGN Jackson
    Mississippi 39216
    Usa
    পরিচালক
    23 Eastbrooke
    FOREIGN Jackson
    Mississippi 39216
    Usa
    American16821760001
    GRAY, Nigel Martin
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    পরিচালক
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    EnglandBritish120162140002
    HARRISON, John Stephen
    1220 Park Avenue
    Apt No 14a
    10128 New York
    Usa
    পরিচালক
    1220 Park Avenue
    Apt No 14a
    10128 New York
    Usa
    American49160010001
    HENNING, David
    Chapel Cottage
    Ashford Hill
    RG19 8BG Thatcham
    Berkshire
    পরিচালক
    Chapel Cottage
    Ashford Hill
    RG19 8BG Thatcham
    Berkshire
    British71530430001
    JONES, Christopher William
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    পরিচালক
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    EnglandBritish274714740001
    MAYNARD, Stefan John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish274905000001
    MCBRINN, William Stephen
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish161340530001
    MULADY, Barry James, Dr
    Springbank
    Oldlands Herons Ghyll
    TN22 3DA Uckfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Springbank
    Oldlands Herons Ghyll
    TN22 3DA Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish13069930001
    NABARRO, Daniel Joseph Nunes
    87 Kingsley Way
    N2 0EL London
    পরিচালক
    87 Kingsley Way
    N2 0EL London
    Canadian/British43350470001
    NEARY, Christopher
    22 Pollards Close
    Cheshunt
    EN7 5JP Waltham Cross
    Hertfordshire
    পরিচালক
    22 Pollards Close
    Cheshunt
    EN7 5JP Waltham Cross
    Hertfordshire
    British47022960002
    RADFORD, Jamie Leigh
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish193131980001
    READ, James Allan
    Little Adelphi
    Flat No 12 10-14 John Adams Street
    WC2N 68A London
    পরিচালক
    Little Adelphi
    Flat No 12 10-14 John Adams Street
    WC2N 68A London
    American32172560003
    REICHER, Andrew William Michael
    60 Croftdown Road
    NW5 1EN London
    পরিচালক
    60 Croftdown Road
    NW5 1EN London
    EnglandBritish42421970002
    REISS, Richard
    1001 Park Avenue
    New York Ny10028 New York
    FOREIGN Usa
    পরিচালক
    1001 Park Avenue
    New York Ny10028 New York
    FOREIGN Usa
    Us Citizen49056890001
    REYNOLDS, James Henry
    89 Whiteknights Road
    RG6 2BB Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    89 Whiteknights Road
    RG6 2BB Reading
    Berkshire
    British68848830001
    RODEN, Mark
    78 Heytesbury Lane
    Dublin 4
    Ireland
    পরিচালক
    78 Heytesbury Lane
    Dublin 4
    Ireland
    Irish68587490001
    RODGERSON, Craig Hilton
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish188334810001

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর01991595
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A fixed and floating security document (the "security document" between the company, certain other chargors as listed in schedule 1 of the security document (together the "chargors") and chase manhattan international limited in its capacity as security agent for the finance parties (the "security agent")
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations of the obligors (as defined) to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) and to the finance parties under the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that l/h and licence property including carlton house salford manchester and derby house merstham surrey with all buildings and fixtures and proceeds of sale please reefer to form 395 and additional pages for full details of charged assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this deed and the various deeds and documents as defined therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over all those properties as defined together with all buildings, erections, fixtures, fittings and fixed plant and machinery (see doc M480C for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bankthe Other Lenders as Defined in the Agreementfor Itself and as Agent for Credit Lyonnais And
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a debenture and a credit agreement both dated december 11TH 1990. this charge and deeds supplemental thereto.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over:- a) l/h property at 28, the broadway, darkes lane, potters bar, hertfordshire. B) l/h property of carlton house, eccles new road, salford, manchester. T/n: cm 542741. together with all buildings erections, fixtures, fittings, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bankt) Other Lenders as Defined in the Credit Agreemen(As Agent for Itself and Credit Lyonnais and The
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "fundamental documents" (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M209 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bankthe Other Lenders (As Defined)for Itself and as Agent for Credit Lyonnais And
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন

    INTER-CITY PAGING LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৭ মার্চ, ২০১৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১০ নভে, ২০১৮ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0