PAYCHANNEL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPAYCHANNEL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01645175
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PAYCHANNEL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    PAYCHANNEL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Challenge House
    International Drive
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PAYCHANNEL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRANSACSYS APPLICATIONS LTD২৩ মে, ২০০৩২৩ মে, ২০০৩
    G2 LIMITED.২০ সেপ, ২০০২২০ সেপ, ২০০২
    TRANSACSYS APPLICATIONS LIMITED ০৯ এপ্রি, ২০০১০৯ এপ্রি, ২০০১
    GIROVEND SYSTEMS LIMITED২১ অক্টো, ১৯৯৭২১ অক্টো, ১৯৯৭
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED২৩ আগ, ১৯৮২২৩ আগ, ১৯৮২
    COLAW ONE LIMITED২১ জুন, ১৯৮২২১ জুন, ১৯৮২

    PAYCHANNEL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    PAYCHANNEL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ মার্চ, ২০১০

    ১৮ মার্চ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 103
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed transacsys applications LTD\certificate issued on 31/07/06
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    PAYCHANNEL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    সচিব
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    British85541780001
    CLARKSON, James Robert
    9 Westwood Close
    The Briars
    WR9 0BD Droitwich Spa
    Worcestershire
    পরিচালক
    9 Westwood Close
    The Briars
    WR9 0BD Droitwich Spa
    Worcestershire
    United KingdomBritish72610550001
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish85541780001
    WHITELOCK, Noel Keith
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish14940620001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    সচিব
    75 Park Road
    W4 3EY London
    British37599910001
    BAILEY, John
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    সচিব
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    British41823950002
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    সচিব
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    সচিব
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    সচিব
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    সচিব
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    সচিব
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    সচিব
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    British43153490002
    CLAIR, Peter
    4 White Hermitage
    Church Road Old Windsor
    SL4 2JX Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    4 White Hermitage
    Church Road Old Windsor
    SL4 2JX Windsor
    Berkshire
    British47537030003
    CLARK, Ronald Thomson
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    British69705410001
    DRUDY, Carmel Ann
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    পরিচালক
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    British40928410001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    GREHS, Barbara
    14 Overy House
    Webber Row
    SE1 8QX London
    পরিচালক
    14 Overy House
    Webber Row
    SE1 8QX London
    British42212470001
    HARRIS, Glyn
    Ty Gwyn
    Boverton Road
    CF61 1YA Llantwit Major
    South Glam
    পরিচালক
    Ty Gwyn
    Boverton Road
    CF61 1YA Llantwit Major
    South Glam
    British8555610001
    KOBEISSI, Mario
    67 Boardwalk Place
    E14 5SE London
    পরিচালক
    67 Boardwalk Place
    E14 5SE London
    British92156280001
    LAING, Andrew Murray
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    পরিচালক
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    British28771390001
    LAVERACK, Harold Thomas
    68 The Holloway
    WR9 7AX Droitwich
    Worcestershire
    পরিচালক
    68 The Holloway
    WR9 7AX Droitwich
    Worcestershire
    British19389720001
    MADISON HAYNE, Hayne
    100 Scenic Highway
    46 Lookout Mountain
    Tennesse
    United States Of America
    পরিচালক
    100 Scenic Highway
    46 Lookout Mountain
    Tennesse
    United States Of America
    American45373130001
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    পরিচালক
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    পরিচালক
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    পরিচালক
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    পরিচালক
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    EnglandBritish78149370002
    SCHOFIELD, Janet Elizabeth
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    পরিচালক
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    British36356290002
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    পরিচালক
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    TRACE, Charles Lawrence
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    পরিচালক
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    EnglandBritish129244340001
    WILLIAMS, Richard Idwal
    Top Flat
    68 Ladbroke Grove
    W11 2PB London
    পরিচালক
    Top Flat
    68 Ladbroke Grove
    W11 2PB London
    British40830150002

    PAYCHANNEL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or the principal debtor (as defined) to the chargee under the terms of the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee assigned and agreed to assign to the bank:(a) the policy of assurance set out in part iv of this schedule and all moneys (including bonuses) that may become payable thereunder.(b) all sums payable to the company in connection with the policies pursuant to section 76 of the insurance companies act 1982. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h & l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough.t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Counter-indemnity & charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details see form 395 ref: M49). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Graig Shipping PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0