PTE GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPTE GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01652047
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PTE GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5190) /

    PTE GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Astute House
    Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PTE GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০০৯

    PTE GROUP LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    PTE GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠা4.72

    ০৫ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    ০৫ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    প্রশাসক নিয়োগ

    2.12B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    2.34B

    ০৩ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    10 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    2.34B

    প্রশাসক নিয়োগ

    2.12B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.34B

    ১৭ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    12 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    96 পৃষ্ঠা2.23B

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.15B

    20 পৃষ্ঠা2.16B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    পরিচালক হিসাবে Sarah Watts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Bryan Stevens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জানু, ২০১১

    ০৭ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 295,934
    SH01

    সচিব হিসাবে Mr Bryan Martin Stevens-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Michael Medley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    10 পৃষ্ঠাAR01

    PTE GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    AHERN, Fergus Craig William
    Grazebrook
    Theydon Mount
    EM16 7PW Epping
    Essex
    পরিচালক
    Grazebrook
    Theydon Mount
    EM16 7PW Epping
    Essex
    United KingdomBritishDirector65524720002
    BERTRAND, Graham Anthony
    York Cottage
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    York Cottage
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director67407000001
    MEDLEY, Michael John
    Reedshaw Farm
    BD22 0NA Cowling
    Keighley
    পরিচালক
    Reedshaw Farm
    BD22 0NA Cowling
    Keighley
    BritishDirector78335060001
    MEDLEY, Michael John
    Cowling
    BD22 0NA Keighley
    Reedshaw Farm
    Yorkshire
    সচিব
    Cowling
    BD22 0NA Keighley
    Reedshaw Farm
    Yorkshire
    Other134507470001
    MEDLEY, Michael John
    Reedshaw Farm
    BD22 0NA Cowling
    Keighley
    সচিব
    Reedshaw Farm
    BD22 0NA Cowling
    Keighley
    BritishCompany Director78335060001
    STEVENS, Bryan Martin
    16 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Lindens House
    Middlesex
    সচিব
    16 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Lindens House
    Middlesex
    149709210001
    WILD, Martin Alastair
    Castlebergh View
    4 Chapel Square
    BD24 9HR Settle
    North Yorkshire
    সচিব
    Castlebergh View
    4 Chapel Square
    BD24 9HR Settle
    North Yorkshire
    BritishManagement Accountant36979030007
    BERTRAND, Carolyn Mary
    York Cottage
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    York Cottage
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director62702760002
    CRONIN, Barry John
    63 Green Dragon Lane
    Winchmore Hill
    N21 2LB London
    পরিচালক
    63 Green Dragon Lane
    Winchmore Hill
    N21 2LB London
    BritishDirector54292260001
    HOUSE, Paul
    187 North Dene Road
    BD22 6QT Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    187 North Dene Road
    BD22 6QT Keighley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director34984030001
    LIQUORISH, John Vaughan
    8 Willow Way
    Sutton In Craven
    BD20 7BL Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    8 Willow Way
    Sutton In Craven
    BD20 7BL Keighley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director31412760002
    MEDLEY, Yvonne
    Reedshaw Farm
    Cowling
    BD22 0NA Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Reedshaw Farm
    Cowling
    BD22 0NA Keighley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director34601070002
    TURNER, William Mark
    Rosedale
    Hawthorne Road
    BB11 2JR Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Rosedale
    Hawthorne Road
    BB11 2JR Burnley
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director66972180002
    WATTS, Sarah Louise
    Goose Lane Farmhouse
    Chilton Polden
    TA7 9ED Bridgwater
    Somerset
    পরিচালক
    Goose Lane Farmhouse
    Chilton Polden
    TA7 9ED Bridgwater
    Somerset
    EnglandBritishDirector49745400003
    WILD, Martin Alastair
    Castlebergh View
    4 Chapel Square
    BD24 9HR Settle
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Castlebergh View
    4 Chapel Square
    BD24 9HR Settle
    North Yorkshire
    EnglandBritishManagement Accountant36979030007

    PTE GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ আগ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £500,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north-east side of barrowford road colne lancashire. T/no:LA807269. Land and buildingson/lying to the north east side of barrowford road colne lancashire. T/no:LA807276. Land and buildings on the north east side of barrowford road coplne lancashire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alliance Leisure Services Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    A maximum sum of £100,000.00 due or to become due from the company to
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land an dbuildings on the north east side of barrowford road colne (t/no LA807269, l/h land and buildings on the northeast side of barrowford road colne (t/no LA807276), f/h land on the north side of north valley road colne (t/no LA557006) for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fergus Craig William Ahern
    • Fergus Craig William Ahern
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ফেব, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৯ মার্চ, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৩ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north-east side of barrowford road colne lancashire pendle title number LA807269. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the property k/a unit D3, braintree road industrial estate, braintree road, south ruislip, hillingdon, greater london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage vivary bridge mill, north valley road, colne, lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ অক্টো, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Former raab karcher premises vivary way colne lancashire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PTE GROUP LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৮ মার্চ, ২০১১প্রশাসন শুরু
    ০৬ মার্চ, ২০১২প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Beesley
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    অভ্যাসকারী
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৬ মার্চ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৩ অক্টো, ২০১৫ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Beesley
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    অভ্যাসকারী
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0