SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01674987
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভ্রমণ সংস্থার কার্যক্রম (79110) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O INTERPATH LTD
    10th Floor One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DUNDON LIMITED০১ নভে, ১৯৮২০১ নভে, ১৯৮২

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৮

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    27 পৃষ্ঠাAM23

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    27 পৃষ্ঠাAM10

    ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE থেকে 10th Floor One Marsden Street Manchester M2 1HWপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    25 পৃষ্ঠাAM10

    বদলি বা অতিরিক্ত প্রশাসক নিয়োগের নোটিশ

    5 পৃষ্ঠাAM11

    প্রশাসককে পদ থেকে অপসারণের আদেশের বিজ্ঞপ্তি

    5 পৃষ্ঠাAM16

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM04

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    25 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসককে পদ থেকে অপসারণের আদেশের বিজ্ঞপ্তি

    29 পৃষ্ঠাAM16

    বদলি বা অতিরিক্ত প্রশাসক নিয়োগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM11

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    23 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    25 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    33 পৃষ্ঠাAM10

    ০২ আগ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Hugo Charles Kimber-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ আগ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr John Daniel Mclaughlin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ আগ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Daniel Mclaughlin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ আগ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Hugo Charles Kimber এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    56 পৃষ্ঠাAM03

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ AM02SOA

    19 পৃষ্ঠাAM02

    ২১ আগ, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা . Eboracum Way Heworth Green York Yorkshire YO31 7RE থেকে 1 st. Peters Square Manchester M2 3AEপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAM01

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KERKAR, Ajay Ajit Peter
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    10th Floor
    পরিচালক
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    10th Floor
    United KingdomIndianCompany Director171005990001
    KIMBER, Hugo Charles
    St. Katharines
    Savernake
    SN8 3BG Marlborough
    St. Katharines Lodge
    England
    পরিচালক
    St. Katharines
    Savernake
    SN8 3BG Marlborough
    St. Katharines Lodge
    England
    EnglandBritishDirector113847000002
    MCLAUGHLIN, John Daniel
    Brookfield Drive
    Timperley
    WA15 6QR Altrincham
    22
    England
    পরিচালক
    Brookfield Drive
    Timperley
    WA15 6QR Altrincham
    22
    England
    United KingdomBritishDirector230948990001
    BADDELEY, Robert Gregory
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    BritishVd28024220004
    CULLEN, Dominique
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    সচিব
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    195246800001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    সচিব
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    192247070001
    MICHEL, Carl Heinrich
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    সচিব
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    BritishDirector107791560001
    WILLIAMSON, Alexandra Dilys
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    British100325220002
    WRAY, Mark Christopher
    32 Hillcrest Avenue
    Nether Poppleton
    YO2 6LD York
    সচিব
    32 Hillcrest Avenue
    Nether Poppleton
    YO2 6LD York
    British25762230002
    ALLAN, Leslie Stewart
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    পরিচালক
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    BritishCompany Director1704690001
    ANDERSON, Ian David
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector163172340002
    ATKINS, Jane Louise
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    পরিচালক
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector207125210001
    ATKINSON, Richard Westaway
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishDirector111861370001
    BADDELEY, Robert Gregory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Great BritainBritishCompany Director28024220020
    BALI, Navneet
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director83088120002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director180993450001
    CREW, James Robert
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector15842470001
    CUST, Nicholas Pury
    Crookhill
    The Village Skelton
    YO3 6XY York
    পরিচালক
    Crookhill
    The Village Skelton
    YO3 6XY York
    United KingdomBritishJoint Managing Director159977730001
    DAVIES, Martin William Oliver
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector98399000002
    FENNEMORE, Roger Arnold
    25 Chapel Street
    Woburn Sands
    MK17 8PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    25 Chapel Street
    Woburn Sands
    MK17 8PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director9399600002
    FERRIN, Eamonn
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United KingdomIrishCompany Director146776900001
    GOENKA, Abhishek
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    পরিচালক
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    United KingdomIndianGeneral Manager192234860001
    HOPE, Stuart Malcolm Ronald
    8 Nesbitt Square
    Coxwell Road
    SE19 3AB London
    পরিচালক
    8 Nesbitt Square
    Coxwell Road
    SE19 3AB London
    BritishExecutive Director49358260001
    JARVIS, Susan
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    পরিচালক
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director199100680002
    JONES, Raymond Anthony Patrick
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector60728450001
    KIMBER, Hugo Charles
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    পরিচালক
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    EnglandBritishExecutive Chairman113847000002
    LEPPARD, Matin Neal
    Parkfield House Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Parkfield House Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director44209650001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    EnglandBritishTreasurer27408660003
    MCLAUGHLIN, John Daniel
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Limited
    Uk
    United Kingdom
    পরিচালক
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Limited
    Uk
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer230948990001
    MENON, Ajit Paramparambath
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director170912720001
    MICHEL, Carl Heinrich
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    পরিচালক
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    EnglandBritishDirector107791560001
    MOUNSER, Ian Peter
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTour Operator50419570001
    NEYLON, Darren Lee
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Director69978820001
    REGAN, Frank
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTour Operator35768770001
    RICHARDS, Patrick Rory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    EnglandBritishCompany Director135751860001

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Superbreak Mini Holidays Group Limited
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUk Companies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানUk Companies Registry
    নিবন্ধন নম্বর2501443
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০১৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০১৯
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০১৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০১৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ২০১৮
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Registered trade mark with tm number UK00002143013; registered trade mark with tm number UK00002372700; registered trade mark with tm number UK00001382488; registered trade mark with tm number UK00001525779; and registered trade mark with tm number UK00002000435. For more information please see schedule 1 of the instrument.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yes Bank Limited, Ifsc Banking Unit (As Lender as Defined in the Debenture))
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ২০১৮একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০১৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ২০১৮
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    N/A.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yes Bank Limited, Ifsc Banking Unit (As Lender (as Defined in the Share Charge))
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ২০১৮একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৬সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ২৩ জুন, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৬সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ২৩ জুন, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Dutch law notarial deed of pledge of shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pledge and pledges as a disclosed right of pledge to the facility agent all its shares and share rights see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৬সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ২৩ জুন, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    English law security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৬সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ২৩ জুন, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A deed of pledge of shares
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares and share rights including any dividend. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Hartford manor hartford northwich t/no CH424893. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All deposits credited to account numbered 45992614 and any deposit or account of any other currency description or designation.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to the debenture dated 3RD february 1995
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities at the date of the supplemental deed or thereafter due owing or incurred by the company to national westminster bank PLC (the "security trustee") and to the beneficiaries (as defined) or any of them (whether under the facility agreements,and the facility documents as defined or otherwise) and by guarantee the obligations of each other company and any other subsidiary of the parent (the guaranteed obligations)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether under any of the facility agreements, the facility documents (as defined therein) or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee and debenture dated 14/6/90
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a lower ground floor of 297/305 grays inn road london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or antfresh limited under the terms of the charge to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M248 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জানু, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please see doc M15.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জানু, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re: dunn miller associates LTD.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ আগ, ২০১৯প্রশাসন শুরু
    ০৫ আগ, ২০২২প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    অভ্যাসকারী
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Tracey Lee Pye
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    অভ্যাসকারী
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Richard John Harrison
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    অভ্যাসকারী
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Andrew James Stone
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    অভ্যাসকারী
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0