FRANK COOPER LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFRANK COOPER LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01676030
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FRANK COOPER LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    FRANK COOPER LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FRANK COOPER LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HMP (BURTON) LIMITED২২ নভে, ১৯৯৬২২ নভে, ১৯৯৬
    TECHTUS LIMITED২৯ আগ, ১৯৯৬২৯ আগ, ১৯৯৬
    HMP (BURTON) LIMITED১১ জুল, ১৯৮৮১১ জুল, ১৯৮৮
    HOLGRAN LIMITED১৭ মার্চ, ১৯৮৩১৭ মার্চ, ১৯৮৩
    POSTFIVE LIMITED০৫ নভে, ১৯৮২০৫ নভে, ১৯৮২
    POSTFIVE LIMITED০৫ নভে, ১৯৮২০৫ নভে, ১৯৮২

    FRANK COOPER LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    FRANK COOPER LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    A18NNN1D

    ২০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Emmett Mcevoy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X17IJSWB

    ২০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Antony David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    X17IJRUX

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Mcdonald-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    XDB2RZBO

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Suzanne Elizabeth Wise এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    XDB2TZBQ

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04
    AXFU1YJY

    কোম্পানির আর্টিকেলগুলিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCC02
    AXFU3YJ0

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ সেপ, ২০১১

    ২৩ সেপ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,000
    SH01
    XU7GRXSU

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    XJGCFWWF

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Ms Suzanne Elizabeth Wise-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XJGCEWWE

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Andrew Michael Peeler-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XJGCDWWD

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03
    XJGCCWWC

    পরিচালক হিসাবে Mr Antony David Smith-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01
    AIUDFWR1

    পরিচালক হিসাবে Andrew Peeler এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01
    AIUD6WRS

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA
    AM6Y7WGJ

    পরিচালক হিসাবে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    XG2JNNS0

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    XB17ANGT

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA
    AETPDN39

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a
    XG581DOS

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b
    XFA3JDK5

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a
    XFA32DKO

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA
    A9B99CPD

    FRANK COOPER LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    AUSTEN, Peter David
    Pippins
    Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    সচিব
    Pippins
    Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    British40203460001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    সচিব
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    সচিব
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    সচিব
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    সচিব
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector37177620001
    AUSTEN, Peter David
    Pippins
    Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Pippins
    Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director40203460001
    BAKER, Peter
    12 Tallow Road
    TW8 8EU Brentford
    Middlesex
    পরিচালক
    12 Tallow Road
    TW8 8EU Brentford
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director112123100001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    পরিচালক
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector47432570002
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    পরিচালক
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinancial Director145901880001
    IRVING, Patrick Haydn
    Hyeswood Guildford Road
    Rudgwick
    RH12 3BX Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Hyeswood Guildford Road
    Rudgwick
    RH12 3BX Horsham
    West Sussex
    BritishDirector19988500001
    KNOX, Virginia Caroline
    Rowbarns Grange North
    Green Dene, East Horsley
    KT24 5RQ Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Rowbarns Grange North
    Green Dene, East Horsley
    KT24 5RQ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director45852840005
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    পরিচালক
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritishDirector99991140001
    LLOYD, Anthony
    St Marys House 25 Victoria Road
    Wargrave
    RG10 8AD Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    St Marys House 25 Victoria Road
    Wargrave
    RG10 8AD Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director21160880001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Secretary/Director26880001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    BritishChief Executive84644240002
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Secretary120645920001
    MOSS, Nicholas Frank Moreton
    Chester High Road
    Windle Hill
    CH64 7TB Neston
    Windle Lodge
    Wirral
    England
    পরিচালক
    Chester High Road
    Windle Hill
    CH64 7TB Neston
    Windle Lodge
    Wirral
    England
    United KingdomBritishDirector134259930001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    পরিচালক
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    BritishChartered Accountant114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Controller87359710001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector42065200002
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director147725160001
    SUMMERLIN, John Michael
    The Rectory
    Harvest Hill
    SL8 5JJ Bourne End
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Rectory
    Harvest Hill
    SL8 5JJ Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector Of Processes & System41514080003
    WILKINSON, Paul Nigel
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    পরিচালক
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    United KingdomBritishCompany Director90533810001
    WISE, Suzanne Elizabeth
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Counsel/Company Secretary136781050001
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector37177620001

    FRANK COOPER LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জানু, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0