QA LEARNING SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামQA LEARNING SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01679488
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    QA LEARNING SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    QA LIMITED০৭ সেপ, ২০০৬০৭ সেপ, ২০০৬
    QA PLC৩০ এপ্রি, ২০০১৩০ এপ্রি, ২০০১
    SKILLSGROUP PLC০৯ মে, ১৯৯৭০৯ মে, ১৯৯৭
    P & P PUBLIC LIMITED COMPANY৩১ জানু, ১৯৮৮৩১ জানু, ১৯৮৮
    P & P MICRO DISTRIBUTORS PUBLIC LIMITED COMPANY১৮ নভে, ১৯৮২১৮ নভে, ১৯৮২

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে০২ জুন, ২০১৭

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠাLIQ13

    ৩০ অক্টো, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Rath House 55-65 Uxbridge Road Slough Berkshire SL1 1SG থেকে Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2ALপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    6 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৬ অক্টো, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    ২২ আগ, ২০১৯ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,161,391.09
    4 পৃষ্ঠাSH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Auth share cap restriction revoked and deleted 22/08/2019
    RES13
    resolution

    ক্যাপিটালাইজেশন বা শেয়ার বোনাস ইস্যুর রেজুলেশন

    Sum of £2297000 is capitalised 22/08/2019
    RES14

    ০২ সেপ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Geddes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৯ আগ, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Seckloe 208 Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    4 পৃষ্ঠাPSC02

    ০৯ আগ, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Qa-Iq Group Limited এর বন্ধ

    3 পৃষ্ঠাPSC07

    ০২ সেপ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে William Robert George Macpherson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৭ আগ, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.003345
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৩ আগ, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,721,069.09
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ৩০ মে, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাCS01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    ৩০ মে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ মে, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Ian Paul Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    RUNNICLES, Nathan Giles
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    United Kingdom
    246765550001
    GEDDES, Paul Robert
    SL1 1SG Slough
    Rath House, 55-65 Uxbridge Road
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    SL1 1SG Slough
    Rath House, 55-65 Uxbridge Road
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNone262110530001
    RUNNICLES, Nathan Giles
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer246765540001
    ATKIN, John Duncan
    20 Hallside Park
    WA16 8NQ Knutsford
    Cheshire
    সচিব
    20 Hallside Park
    WA16 8NQ Knutsford
    Cheshire
    British4769830001
    BIRCHALL, Michael John
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British56115530002
    GIBSON, Colin John
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    BritishFinance Director72748350001
    GIBSON, Colin John
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director72748350001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector13800580002
    JOHNSON, Ian Paul
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    England
    সচিব
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    England
    BritishCompany Director136279590001
    LUMB, Tony
    1 The Corner House
    Aimson Road West Timperley
    WA15 7XP Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    1 The Corner House
    Aimson Road West Timperley
    WA15 7XP Altrincham
    Cheshire
    BritishAccountant110543530001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    সচিব
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    BritishAccountant101309030001
    SAVAGE, Mark Anthony William
    3 Lancaster Court
    Well Place
    GL50 2PJ Cheltenham
    সচিব
    3 Lancaster Court
    Well Place
    GL50 2PJ Cheltenham
    British81345070002
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    সচিব
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    BritishChartered Accountant124180840001
    ATKIN, John Duncan
    20 Hallside Park
    WA16 8NQ Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    20 Hallside Park
    WA16 8NQ Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director4769830001
    BEAUMONT, John Richard
    The Manor House
    85 High Street
    RH16 2HN Lindfield
    Sussex
    পরিচালক
    The Manor House
    85 High Street
    RH16 2HN Lindfield
    Sussex
    BritishDirector92701330001
    BURGESS, Keith, Dr
    Hengrove
    The Chivery
    HP23 6LE Tring
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hengrove
    The Chivery
    HP23 6LE Tring
    Hertfordshire
    BritishDirector73570840001
    BURNHAM, Robert
    Fairfield Brook Lane
    SK9 7QG Alderley Edge
    Cheshire
    পরিচালক
    Fairfield Brook Lane
    SK9 7QG Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director50665730002
    CARNWATH, Alison Jane, Dame
    The Old Dairy
    Sidbury
    EX10 0QR Sidmouth
    Devon
    পরিচালক
    The Old Dairy
    Sidbury
    EX10 0QR Sidmouth
    Devon
    EnglandBritishDirector73581270001
    EATON, Wilfred Christopher, Dr
    Ladybrook House
    Thame Road
    OX10 7DA Warborough
    Oxon
    পরিচালক
    Ladybrook House
    Thame Road
    OX10 7DA Warborough
    Oxon
    United KingdomBritishCompany Director21420730001
    FISHER, Anthony Frederick
    Dunally House Walton Lane
    TW17 8LQ Shepperton
    Middlesex
    পরিচালক
    Dunally House Walton Lane
    TW17 8LQ Shepperton
    Middlesex
    BritishCompany Director8142980002
    FISHER, Peter
    Woodcroft 86 Whalley Road
    Wilpshire
    BB1 9LJ Blackburn
    পরিচালক
    Woodcroft 86 Whalley Road
    Wilpshire
    BB1 9LJ Blackburn
    BritishCompany Director62613580001
    GIBSON, Colin John
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishDirector72748350001
    GRANT, Charles
    New Dairy House Farm
    Batherton Lane, Batherton
    CW5 7QH Nantwich
    Cheshire
    পরিচালক
    New Dairy House Farm
    Batherton Lane, Batherton
    CW5 7QH Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector67855570001
    HOFMANN, Claes
    Sjovillans Gard
    S-179 75
    Ska
    Sweden
    পরিচালক
    Sjovillans Gard
    S-179 75
    Ska
    Sweden
    SwedishDirector58754550001
    HOUGH, Robert Eric
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    পরিচালক
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritishDirector38776360001
    HUBEAUX, Christian
    3 Rue Giovanni Gambini
    FOREIGN 1206 Geneva
    Switzerland
    পরিচালক
    3 Rue Giovanni Gambini
    FOREIGN 1206 Geneva
    Switzerland
    FrenchCompany Director11215290001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    পরিচালক
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritishDirector26032950002
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector13800580002
    INCE, David Leslie
    20 Clarence Road
    SL4 5AF Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    20 Clarence Road
    SL4 5AF Windsor
    Berkshire
    BritishDirector67855650002
    JOHNSON, Ian Paul
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director136279590001
    KAUFFMAN, John
    The Grange
    Fryth Finchampstead
    RG40 3RN Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    The Grange
    Fryth Finchampstead
    RG40 3RN Wokingham
    Berkshire
    BritishManaging Director113989000001
    LIVESEY, Philip Grimshaw
    15 Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    15 Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director50114010002
    MACPHERSON, William Robert George
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    55-65 Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director132097710001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritishChairman113992220001
    MCGOUN, Michael Frederick
    The Old Rectory Church Lane
    Mobberley
    WA16 7RD Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    The Old Rectory Church Lane
    Mobberley
    WA16 7RD Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director8300340001

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Seckloe 208 Limited
    Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House 55-65
    Berkshire
    United Kingdom
    ০৯ আগ, ২০১৯
    Uxbridge Road
    SL1 1SG Slough
    Rath House 55-65
    Berkshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House United Kingdom
    নিবন্ধন নম্বর3684770
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    55-65 Uxbridge Rooad
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    United Kingdom
    ২৩ জুন, ২০১৭
    55-65 Uxbridge Rooad
    SL1 1SG Slough
    Rath House
    Berkshire
    United Kingdom
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland & Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর5091695
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ৩০ মে, ২০১৭২৩ জুন, ২০১৭কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All deposits now and in the future credited to account designation 630174466 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Premises at st crispin way hurstwood enterprises park haslingden lancashire rossendale t/n LA761231. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 gleneagle road and 5 station approach streatham title no sgl 296424 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land and property situate on the south side of dale street bilston wolverhampton title no sf 112396 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 1 carrs industrial estate, haslingden, rossendale, lancs. Title no. La 506843 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 1 gleneagle road and 5 station approach streatham london sgl 296424.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ নভে, ১৯৮৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জানু, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and property situate on the south side of dale street bilston wolverhampton west midlands sf 112396.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জানু, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land forming part of the property comprised in title no la 494564.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    QA LEARNING SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ অক্টো, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৯ মে, ২০২১ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    অভ্যাসকারী
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    অভ্যাসকারী
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0