ELVADENE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামELVADENE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01680157
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ELVADENE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    ELVADENE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ELVADENE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    ELVADENE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ১০ মে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium cancelled 26/04/2013
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৩ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael James Kachmer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Graham Philip Brisley Veal-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kevin Blades এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ০৮ মে, ২০১০ তারিখে Prima Secretary Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Thomas Doerr এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Adrian David Gray-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    ELVADENE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    পরিচালক
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    পরিচালক
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    JELLY, Jennifer
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    সচিব
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British1745390001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    সচিব
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    সচিব
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    AIREY, Andrew Robert
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    EnglandBritish54515590004
    BARKER, Simon Charles
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    পরিচালক
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    British113730600001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    পরিচালক
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BRAY, Kenneth Ivor
    Garden Cottage Church Street
    Denton
    NG32 1LE Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Garden Cottage Church Street
    Denton
    NG32 1LE Grantham
    Lincolnshire
    British45153770001
    CAMPBELL, James
    Rent Street Cottages
    60 Chipperfield Road
    HP3 0JW Bovingdon
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Rent Street Cottages
    60 Chipperfield Road
    HP3 0JW Bovingdon
    Hertfordshire
    British53496740001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    পরিচালক
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GEORGE, Alan
    Oak Tree Cottage Robin Hood Lane
    Sutton Green
    GU4 7QG Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Oak Tree Cottage Robin Hood Lane
    Sutton Green
    GU4 7QG Guildford
    Surrey
    British1745400001
    HAMPTON, Mark Richard
    Bankside 5 Parsonage Road
    HP8 4JW Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Bankside 5 Parsonage Road
    HP8 4JW Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    British80408810001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    HOUGHTON, Reece
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    পরিচালক
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    British27953100001
    JELLY, Aubrey Bruce, Mr.
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    পরিচালক
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    United KingdomBritish82764370003
    JELLY, Jennifer
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British1745390001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    পরিচালক
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    পরিচালক
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    MILLER, Stuart Purves
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish98718070001
    ROLT, Jeremy Charles
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish35716980001
    TONER, Robert Anthony
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish70516300002
    WHITELING, Mark Argent
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    পরিচালক
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish101297630001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    ELVADENE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold premises at station road west,ashvale,aldershot,hampshire GU12 5XA; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জানু, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or proceeds of sale thereof. Fixed & floating charges on the: undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts and the benefit of any licences (see doc M9).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company.
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0