ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01773962
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ব্যবসায়িক এবং গার্হস্থ্য সফ্টওয়্যার উন্নয়ন (62012) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Eos, Axis 6, Rhodes Way
    C/O Sirsidynix
    WD24 4YW Watford
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INFORMATION MANAGEMENT AND ENGINEERING LIMITED২৯ নভে, ১৯৮৩২৯ নভে, ১৯৮৩

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Asset transfer agreement 05/06/2019
    RES13

    ৩১ মে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Daniel Jay Munro-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে John Scott Askew এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২৯ জানু, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Eos, First Flr, Axis 6 Rhodes Way Watford WD24 4YW England থেকে Eos, Axis 6, Rhodes Way C/O Sirsidynix Watford WD24 4YWপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৭ জানু, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Sirsidynix 54 Clarendon Road Watford Wd17 1Duwd17 1Du থেকে Eos, First Flr, Axis 6 Rhodes Way Watford WD24 4YWপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১৫ থেকে ৩০ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জুন, ২০১৬

    ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 804,785
    SH01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ জুন, ২০১৫

    ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 108,479
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Big Yellow Self Storage Company a Limited 1, Ascot Road Watford WD18 8AL এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ জুন, ২০১৪

    ২৭ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 108,479
    SH01

    সচিব হিসাবে Mr. John Scott Askew-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে John Gardiner Iii এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ

    2 পৃষ্ঠাSH10

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MUNRO, Daniel Jay
    Rhodes Way
    C/O Sirsidynix
    WD24 4YW Watford
    Eos, Axis 6,
    England
    সচিব
    Rhodes Way
    C/O Sirsidynix
    WD24 4YW Watford
    Eos, Axis 6,
    England
    244490400001
    DAVISON JR, William Charles
    N. Ashton Blvd
    Suite 500
    84043 Lehi
    3300
    Utah
    United States
    পরিচালক
    N. Ashton Blvd
    Suite 500
    84043 Lehi
    3300
    Utah
    United States
    United StatesAmericanCeo167741700001
    ASKEW, John Scott, Mr.
    Rhodes Way
    C/O Sirsidynix
    WD24 4YW Watford
    Eos, Axis 6,
    England
    সচিব
    Rhodes Way
    C/O Sirsidynix
    WD24 4YW Watford
    Eos, Axis 6,
    England
    187530370001
    CLARK, William David
    5 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    সচিব
    5 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    BritishCompany Secretary21438440001
    COOPER, Peter Francis
    2 Chapel End
    Sawtry
    PE17 5TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    সচিব
    2 Chapel End
    Sawtry
    PE17 5TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    British17354040001
    DICKSON, James Allison
    66 Harpswood Lane
    Saltwood
    CT21 4BJ Hythe
    Kent
    সচিব
    66 Harpswood Lane
    Saltwood
    CT21 4BJ Hythe
    Kent
    British7658290001
    HENDERSON, Helen Lesley
    The Gallery
    Sonning Eye
    RG4 6TP Reading
    সচিব
    The Gallery
    Sonning Eye
    RG4 6TP Reading
    BritishInformation Scientist51054560001
    TWINE, Timothy James
    Upper High Street
    TA1 3PZ Taunton
    12
    Somerset
    United Kingdom
    সচিব
    Upper High Street
    TA1 3PZ Taunton
    12
    Somerset
    United Kingdom
    British45957810002
    CHEATHAM, Scot
    Faraday Avenue
    CA 92008-720 Carlsbad
    2292
    California
    Usa
    পরিচালক
    Faraday Avenue
    CA 92008-720 Carlsbad
    2292
    California
    Usa
    UsaAmericanCompany Director47317980002
    CONNOLLY, Gerard Vincent
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    IrishDirector57063820001
    FENSOME, Graham Ashley
    3 Hunters Park
    HP4 2PT Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    3 Hunters Park
    HP4 2PT Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director37351820001
    FRYE, Joseph Milton
    8 Fox Lane
    Westcote Barton
    OX7 7BS Chipping Norton
    Oxfordshire
    পরিচালক
    8 Fox Lane
    Westcote Barton
    OX7 7BS Chipping Norton
    Oxfordshire
    AmericanCompany Director37560570001
    GARDINER III, John Houston
    N. Ashton Blvd
    Suite 500
    84043 Lehi
    3300
    Utah
    Usa
    পরিচালক
    N. Ashton Blvd
    Suite 500
    84043 Lehi
    3300
    Utah
    Usa
    United States Of AmericaAmericanNone188995160001
    HENDERSON, Helen Lesley
    The Gallery
    Sonning Eye
    RG4 6TP Reading
    পরিচালক
    The Gallery
    Sonning Eye
    RG4 6TP Reading
    United KingdomBritishInformation Scientist51054560001
    INGLEBY, Bryan Clifford
    Wentworth 355 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    পরিচালক
    Wentworth 355 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    BritishDirector7658300001
    LOWTHER, David John
    12 Pensford Avenue
    Kew
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    12 Pensford Avenue
    Kew
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    BritishDirector43607630001
    NOERR, Kathleen Tucker
    Flat 2
    14 Muswell Hill Road
    N6 5UG London
    পরিচালক
    Flat 2
    14 Muswell Hill Road
    N6 5UG London
    AmericanCompany Director18577740001
    NOERR, Peter Leslie, Dr
    14 Muswell Hill Road
    N6 5UG London
    পরিচালক
    14 Muswell Hill Road
    N6 5UG London
    BritishCompany Director17354070001
    PATTERSON, Mark Douglas
    5838 Edison Place
    Carlsbad Ca
    FOREIGN 92008-6596 Usa
    পরিচালক
    5838 Edison Place
    Carlsbad Ca
    FOREIGN 92008-6596 Usa
    AmericanManager47091280001
    RYDEN, Alan Frederic
    2 Lime Tree Walk
    HP7 9HY Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    2 Lime Tree Walk
    HP7 9HY Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director5577060001
    SAADAT, Tony
    1653 Aryana Drive
    FOREIGN Encinitas, Ca
    San Diego 92024
    Usa
    পরিচালক
    1653 Aryana Drive
    FOREIGN Encinitas, Ca
    San Diego 92024
    Usa
    CanadianCeo114997340001
    TRACEY, Robin Nigel
    Ivy Cottage Little Bookham Common
    Bookham
    KT23 3HY Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Ivy Cottage Little Bookham Common
    Bookham
    KT23 3HY Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishConsultant15793170001
    TWINE, Timothy James
    Upper High Street
    TA1 3PZ Taunton
    12
    Somerset
    United Kingdom
    পরিচালক
    Upper High Street
    TA1 3PZ Taunton
    12
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector45957810003
    WEST, Colin Roy
    15 Sherford Road
    Haydon Wick
    SN25 3PR Swindon
    পরিচালক
    15 Sherford Road
    Haydon Wick
    SN25 3PR Swindon
    BritishBusiness Consultant34775170001
    BENEVENT MANAGEMENT AV
    Regenflaan 54 Bus 2
    B-1000 Brussells
    Belgium
    কর্পোরেট পরিচালক
    Regenflaan 54 Bus 2
    B-1000 Brussells
    Belgium
    17354060001

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ৩১ মে, ২০১৭কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    ELECTRONIC ONLINE SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing the obligations of the tenant to the landlord (as defined in the rent deposit deed)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £15,194 together with any other sums paid into the account with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • St. John Street Investment Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০১৩সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ১১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Venture Founders Fund Limited and Beneventure Founders Risicokapitaalfonds Ii N.V.
    ব্যবসায়
    • ১৭ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মার্চ, ১৯৯৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease dated 17TH may 1991
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £6250 and any other sums.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • St John Street Investment Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease dated 17TH may 1991
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £6250 and any other sums.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • St John Street Investment Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ এপ্রি, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or information made easy limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please see doc M9. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0