MICROGEN IQA LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMICROGEN IQA LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01793504
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MICROGEN IQA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7222) /

    MICROGEN IQA LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MICROGEN IQA LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    IMAGO QA LIMITED০৫ আগ, ১৯৯৭০৫ আগ, ১৯৯৭
    SOFTWARE QUALITY ASSURANCE LIMITED১৭ আগ, ১৯৮৮১৭ আগ, ১৯৮৮
    LIKEPRIME LIMITED২১ ফেব, ১৯৮৪২১ ফেব, ১৯৮৪

    MICROGEN IQA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    MICROGEN IQA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৯ জুন, ২০১০ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৮ ফেব, ২০১০

    ০৮ ফেব, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,301,594.9
    SH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Philip Basil Wood-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ms Anjum Siddiqi-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ms Anjum Siddiqi-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    MICROGEN IQA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SIDDIQI, Anjum
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    সচিব
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    BritishSolicitor129229830002
    SIDDIQI, Anjum
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    পরিচালক
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishSolicitor129229830002
    WOOD, Philip Basil
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    পরিচালক
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishDirector72282230002
    BEED, Christopher Martin Vermulen
    12 The Brambles
    SG8 9NQ Royston
    Hertfordshire
    সচিব
    12 The Brambles
    SG8 9NQ Royston
    Hertfordshire
    British63619230002
    FARRELLY, Ian Brian
    Park Avenue
    GU15 2NG Camberley
    20
    Surrey
    সচিব
    Park Avenue
    GU15 2NG Camberley
    20
    Surrey
    BritishSolicitor71425280002
    HYND, Peter Geoffrey
    6 Ridgeway
    WD3 7NS Rickmansworth
    Hertfordshire
    সচিব
    6 Ridgeway
    WD3 7NS Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishConsultant16060050001
    LIDDLE, Gerald Ernest
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    সচিব
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    BritishDirector8458270002
    LIDDLE, Gerald Ernest
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    সচিব
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    BritishDirector8458270002
    SMITH, Kathryn Elizabeth
    5 Meade Close
    CM11 1DF Billericay
    Essex
    সচিব
    5 Meade Close
    CM11 1DF Billericay
    Essex
    British23951340001
    BLACK, Kenneth
    Old Orchard Place
    Twyford Adderbury
    OX17 3JD Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Old Orchard Place
    Twyford Adderbury
    OX17 3JD Banbury
    Oxfordshire
    BritishOperations Director73429140002
    CUTLER, David Richard
    Manor Farm Barn
    HP22 4PA Wingrave
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Manor Farm Barn
    HP22 4PA Wingrave
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant71790680001
    GOODWIN, Graham John
    13 Hawkshead Close
    BR1 4TJ Bromley
    Kent
    পরিচালক
    13 Hawkshead Close
    BR1 4TJ Bromley
    Kent
    BritishComputer Auditor6313770001
    HYND, Peter Geoffrey
    6 Ridgeway
    WD3 7NS Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Ridgeway
    WD3 7NS Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishConsultant16060050001
    LIDDLE, Gerald Ernest
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    Great BritainBritishDirector8458270002
    PHILLIPS, Michael Scott
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    পরিচালক
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector59751680001
    QUENTIN, Geoffrey Peter
    4 Tyrone Road
    Thorpe Bay
    SS1 3HF Southend On Sea
    Essex
    পরিচালক
    4 Tyrone Road
    Thorpe Bay
    SS1 3HF Southend On Sea
    Essex
    BritishComputer Consultant19964220001
    SMITH, Kathryn Elizabeth
    5 Meade Close
    CM11 1DF Billericay
    Essex
    পরিচালক
    5 Meade Close
    CM11 1DF Billericay
    Essex
    BritishSecretary23951340001
    SMITH, Michael Andrew
    Acorn House
    Potash Road
    CM11 1HG Billericay
    Essex
    পরিচালক
    Acorn House
    Potash Road
    CM11 1HG Billericay
    Essex
    United KingdomBritishComputer Systems Consultant91541370001
    STACEY, Edward Paul
    3 Fen End
    Over
    CB4 5NE Cambridge
    পরিচালক
    3 Fen End
    Over
    CB4 5NE Cambridge
    United KingdomBritishConsultant125815970001
    TOMLINSON, Gavin Malcolm
    Brambles
    Briary Wood End
    AL6 0TD Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Brambles
    Briary Wood End
    AL6 0TD Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector77645310001
    TROTTER, Keith David
    Felbrigg 8 Knighton Lane
    IG9 5HD Buckhurst Hill
    Essex
    পরিচালক
    Felbrigg 8 Knighton Lane
    IG9 5HD Buckhurst Hill
    Essex
    BritishChief Executive Officer71662430001
    WILSHER, Mark
    7 Saffron Wharf
    20 Shad Thames
    SE1 2YQ London
    পরিচালক
    7 Saffron Wharf
    20 Shad Thames
    SE1 2YQ London
    EnglandEnglishAccountant126617330001

    MICROGEN IQA LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Industrial Development Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    All assets debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জানু, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan stock instrument dated 2ND november 1998 and this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • M-J Technologies Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a first fixed charge all our book and other debts present and future as are not sold to and bought by alex. Lawrie receivables financing limited under an agreement dated the 22 june 1998 and by way of floating charge on all proceeds of our book and other debts present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জানু, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on book and other debts present and future and the proceeds thereof as are not sold to or bought by the chargee under the terms of an agreement dated 5 april 1994. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alex Lawrie Receivables Financing LTD
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MICROGEN IQA LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ জুল, ২০১১ভেঙে গেছে
    ০৯ জুন, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0