BROADGATE SQUARE LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBROADGATE SQUARE LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01797326
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BROADGATE SQUARE LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    BROADGATE SQUARE LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BROADGATE SQUARE LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    WATLING (108) PLC০৫ মার্চ, ১৯৮৪০৫ মার্চ, ১৯৮৪

    BROADGATE SQUARE LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২১

    BROADGATE SQUARE LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Charles John Middleton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ৩১ ডিসে, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Bruce Michael James এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ জুন, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২২ ডিসে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ২২ ডিসে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Bruce Michael James-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Charles John Middleton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Jonathan Charles Mcnuff-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nigel Mark Webb এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sarah Morrell Barzycki এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Timothy Andrew Roberts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lucinda Margaret Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    BROADGATE SQUARE LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    সচিব
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    সচিব
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    British1898090001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    সচিব
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    সচিব
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    পরিচালক
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    পরিচালক
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    CAMP, David John
    11 Walham Grove
    SW6 London
    পরিচালক
    11 Walham Grove
    SW6 London
    BritishNew Business Director4807190002
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    পরিচালক
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    পরিচালক
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    BritishFinancial Director52294450003
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishAssociate Director73961570001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    পরিচালক
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    BritishSolicitor36631180001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    পরিচালক
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    LIPTON, Stuart Anthony, Sir
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    পরিচালক
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritishDirector Of Companies2068540001
    MANNION, Michael John Francis
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    পরিচালক
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCivil Engineer57126040001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    পরিচালক
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    পরিচালক
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman & Md British Land Co41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    পরিচালক
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    RIVLIN, Paul Denis
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    পরিচালক
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    BritishDirector Of Companies2068550001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    পরিচালক
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    ROGERS, Peter William
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    পরিচালক
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    EnglandBritishDirector Of Companies118055820001
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001

    BROADGATE SQUARE LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Broadgate City Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ১৪ ডিসে, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর01769078
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    BROADGATE SQUARE LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ফেব, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement as amended by the override agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The benefit of account no.5001 101 4037 with the mortgagee in the name of the company (the rental account). The benefit of account no.5001 101 4038 with the mortgagee in the name of the company (the interest hedging account) (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Fuji Bank Limited (As Agent and Trustee for the Banks)
    ব্যবসায়
    • ১২ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "overide agreement" dated 23RD november 1992 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See doc ref M98 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement (as amended by the override agreement)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The benefit of each and every interest rate hedging agreement. Interest hedging account no.120588 And all monies standing to the credit thereof. All rents licence fees and other like sums. The benefit of rental account no.65692.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • American Express Bank Limited (As Agent and Trustee for the Banks)
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and as trustee to the banks under the terms of a loan agreement dated 26.9.88 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that land lying to the north east of eldon street title no egl 158030 all that land at broad street station title no egl 179443 all that property described in the first schedule to a conveyance dated 25.11.87 and made between british railways board and the company title no egl 208120 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • America Express Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ১২ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a loan agreement dated 1ST july 1987 and under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that property situate at the site of the former broad street station london EC2 being east of the junction of sun street & appold street forming part of the access to phases 1, 2, 3, 4 & 5 of the broadgate development london EC2 & all plant equipment & materials.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • American Express Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ০৯ ডিসে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to british railways board under the terms of a principal agreement dated 2ND april 1985 and a deed of covenant dated 25.06.85 & the payment of the secured sums (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that property situate to the east of sun street & appold street forming part of the access to phases 1, 2, 3, 4 & 5 of the broadgate development london EC2.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Railways Board
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Second legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to british railways board under the terms of a principal agreement dated 2/4/85 and a deed of covenant dated 25/6/85 and the payment of the secured sums (as defined).
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that property situate to the east of sun street, and appold street forming part of the access to phases 1,2,3,4 & 5 of the broadgate development london EC2.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Railways Board
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 25.6.85 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First legal mortgage over all property situate at broad street, station london E2. Fixed charge on all plant & equipment of the company from time to time upon the property described above and all materials belonging to the company at any time or from time to time situated thereon for the purpose of the development of the said property on behalf of the mortgagee.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • American Express Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The performance and observance of the obligations of rosehaugh stanhope developments PLC ("rsd") to the "board" ("british railways board") under the principal agreement dated 2ND april 1985 (as defined) and the chargor's obligations under the deed of covenant dated 25TH june 1985 (as defined) and/or all moneys due to the "board"(the "secured sums" as defined) registered pursuant to chapter 1 part xii of the companies act 1985. on the 14TH august 1986
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the site of the former broad street station london EC2 being part of the land described in the principal agreement as "sub site ii" (see doc for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Railways Board
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC. To the chargee pursuant to the principal agreement dated 2ND april, 1985 and a deed of covenant dated 25TH june, 1985.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land forming part of the former goods yard to the west of broad street station, london, EC2. (See doc M21).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Railways Board
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to the chargee pursuant to a development agreement dated 2ND april, 1985 and a deed of covenant dated 25TH june, 1985.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The agregate of all monies (including interest) standing to the credit of the account of the company at barclays bank PLC, account no. 21082736. (see doc M20).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Railways Board
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ফেব, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to the chargee pursuant to the development agreement dated 2ND april, 1985 and a deed of covenant dated 25TH june 1985.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The principal sum maintained in the account of the company with barclays bank PLC being account no 21082744. (see doc M19).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Railways Board
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal & equitagle charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুন, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Securing all moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 25.6.85 and/or this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A) first legal mortgage over f/h & l/h property at broad st, station, london EC2 b) first fixed equitable charge over the f/h & l/h property acquired by the company c) first floating charge over the f/h & l/h property acquired by the company and the undertaking of the company and all its other property, assets, rights, present and future. (See doc M18 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • American Express Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুন, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0