MANITOWOC (UK) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMANITOWOC (UK) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01803796
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    MANITOWOC (UK) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp The Spark
    Drayman's Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    S & W BERISFORD LIMITED১৪ সেপ, ১৯৯২১৪ সেপ, ১৯৯২
    BERISFORD NOMINEES LIMITED০৮ মে, ১৯৮৯০৮ মে, ১৯৮৯
    S. & W. BERISFORD (NOMINEES) LIMITED০৩ মে, ১৯৮৪০৩ মে, ১৯৮৪
    FINCHVOTE LIMITED২৮ মার্চ, ১৯৮৪২৮ মার্চ, ১৯৮৪

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২০

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ০৫ জুল, ২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX থেকে C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Drayman's Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৬ মে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Delphine Guinand-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ মে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Thomas Lee Doerr এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২২ এপ্রি, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brian Patrick Regan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ এপ্রি, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Antoniuk এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২০ নভে, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    সংশোধিত হিসাব নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAAMD

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ২০ নভে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২০ নভে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ সেপ, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Manitowoc Group (Uk) Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ২০ নভে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Antoniuk-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Thomas Lee Doerr-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Louis Frederick Raymond এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Graham Philip Brisley Veal এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adrian David Gray এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ নভে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    কর্পোরেট সচিব
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর4363143
    94529700001
    GUINAND, Delphine
    66 Chemin Du Moulin Carron
    69570
    Dardilly
    Mcg France
    France
    পরিচালক
    66 Chemin Du Moulin Carron
    69570
    Dardilly
    Mcg France
    France
    FranceFrenchSenior Emea Legal Council296711020001
    REGAN, Brian Patrick
    One Park Plaza
    11270 West Park Plaza, Suite 1000
    Milwaukee
    The Manitowoc Company, Inc
    United States
    পরিচালক
    One Park Plaza
    11270 West Park Plaza, Suite 1000
    Milwaukee
    The Manitowoc Company, Inc
    United States
    United StatesAmericanVp And Corporate Controller295367970001
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    সচিব
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    সচিব
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    ANTONIUK, David
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United StatesAmericanDirector240868140001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    পরিচালক
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritishAccountant79449700002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCorporate Treasurer6996370001
    DOERR, Thomas Lee
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United StatesAmericanSolicitor240868220001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    পরিচালক
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United StatesSolicitor134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishFinance Director45532880003
    GILL, Martin John
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    পরিচালক
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    EnglandBritishFinance Manager58291030001
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    পরিচালক
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritishChartered Accountant61620710001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    পরিচালক
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritishAccountant146072380001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary17023730002
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    পরিচালক
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmericanCompany Director134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    পরিচালক
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmericanCompany Director136570610001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    মনোনীত পরিচালক
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    RAYMOND, Louis Frederick
    South 44th Street
    54220 Manitowoc
    2400
    Wisconsin
    Usa
    পরিচালক
    South 44th Street
    54220 Manitowoc
    2400
    Wisconsin
    Usa
    United StatesAmericanAttorney208080730001
    STUART, Charles Murray
    Longacre Guildford Road
    Chobham
    GU24 8EA Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Longacre Guildford Road
    Chobham
    GU24 8EA Woking
    Surrey
    BritishCompany Director/Consultant36073540001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director43215170003
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    BritishAccountant47433990002
    WILTSHIRE, Harold Phillip
    Dipley Mill
    Dipley
    RG27 8JP Hartley Wintney
    Hampshire
    পরিচালক
    Dipley Mill
    Dipley
    RG27 8JP Hartley Wintney
    Hampshire
    BritishCompany Director930220001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর331247
    75310650003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    কর্পোরেট পরিচালক
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    75310650002
    BERISFORD HOLDINGS LIMITED
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    40239460002
    BERISFORD PROPERTY(INVESTMENTS) LIMITED
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    29257590003

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Network 421
    Radclive Road
    MK18 4FD Gawcott
    Manitowoc House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    ২৭ জুল, ২০১৭
    Network 421
    Radclive Road
    MK18 4FD Gawcott
    Manitowoc House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর109849
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    ১৫ জুল, ২০১৬
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর2992272
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MANITOWOC (UK) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC, as Facility Agent
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0