GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01805442
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    ২৩ ডিসে, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৫ অক্টো, ২০১০ তারিখে Mr Adam Christopher Walker-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ সেপ, ২০১০ তারিখে Miss Julie Louise Wilson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ১১ আগ, ২০১০ তারিখে John William Burton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Rachel Jacobs-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Gareth Richard Wright-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Mark Henry Kerswell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০২ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Miss Julie Louise Wilson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ২৭ নভে, ২০০৯ তারিখে Adam Christopher Walker-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    সচিব
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    পরিচালক
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    RIGBY, Peter Stephen
    Appledown House
    The Croft
    GL7 4BB Fairford
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Appledown House
    The Croft
    GL7 4BB Fairford
    Gloucestershire
    EnglandBritish69164290002
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish131115190001
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    সচিব
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    সচিব
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    সচিব
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    সচিব
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    সচিব
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    সচিব
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    সচিব
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    পরিচালক
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    পরিচালক
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    RIDINGS, Stephen
    10a Belsize Park Gardens
    NW3 London
    পরিচালক
    10a Belsize Park Gardens
    NW3 London
    British45198530001
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    পরিচালক
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    পরিচালক
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the charge)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See M182 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Guaranty Trust Companyof New York (As Agent)
    • Hill Samuel Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All bookdebts of the company present & future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ulster Factors Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of set off
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of set off
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum on sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company, with lloyds bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 23 may 84.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All assets with present and future including uncalled capital by way of floating charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Grosvenor Press PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 23 may 84.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h and l/h property of the company and all buildings and structures erected thereon and all fixtures and fittings and effects.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Albion Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0