LEASECONTRACTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLEASECONTRACTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01810100
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LEASECONTRACTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নতুন গাড়ি এবং হালকা মোটরযান বিক্রয় (45111) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    LEASECONTRACTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LEASECONTRACTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JORDANS 160 PUBLIC LIMITED COMPANY১৮ এপ্রি, ১৯৮৪১৮ এপ্রি, ১৯৮৪

    LEASECONTRACTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    LEASECONTRACTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    11 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৫ সেপ, ২০২৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৫ সেপ, ২০২২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৫ সেপ, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৫ সেপ, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom থেকে Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    ১৭ অক্টো, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom থেকে 1 More London Place London SE1 2AFপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৬ সেপ, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    ২৩ জুল, ২০১৯ তারিখে সচিব হিসাবে Oakwood Corporate Secretary Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ২৩ জুল, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Key Leasing Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    ২৩ জুল, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Ige Usa Investments Limited এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ১১ জুন, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ০৪ ফেব, ২০১৯ তারিখে Norris Andrew Geldard-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৩ নভে, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Ige Usa Investments এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ৩০ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anthony William Greenway এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Norris Andrew Geldard-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Stewart Girling-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ আগ, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom থেকে 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১১ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Ige Usa Investments এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    LEASECONTRACTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর7038430
    146358090001
    GELDARD, Norris Andrew
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish244576750001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    পরিচালক
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    ABBOTT, Courtenay
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    সচিব
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    172560620001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    সচিব
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    British45103500001
    ESSEX, Alicia
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    সচিব
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    British55569560002
    FRENCH, Ann
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    সচিব
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    161504050001
    JOHNSON, Paul Robert
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    সচিব
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    British106143590001
    KERSHAW, Simon John
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    সচিব
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    British106236300001
    PATMORE, Ian Robert
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    সচিব
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    British64498630002
    PEERMOHAMED, Zahra
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    সচিব
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    192967230001
    RYLATT, Diane
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    সচিব
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    British46068950001
    TAYLOR, Timothy John
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    British42497260001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ANDERSON, Roger
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    British60138290001
    BECQUE, Geoffrey Frederick
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14428770001
    BURR, Jonathan Charles
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish49902210001
    CHAPMAN, Mark Andrew
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    পরিচালক
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    British54283410002
    CHAPMAN, Mark Andrew
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    পরিচালক
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    British54283410001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    পরিচালক
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    EnglandBritish45103500001
    D'ADDA, Alessandro Pietro
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish47772540001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    পরিচালক
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    DUFF, Paul Anthony
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    পরিচালক
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    British122035530001
    FARRAR, Daniel
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    British42497200001
    FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    পরিচালক
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish139406230001
    FORD, Toby Duncan
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    পরিচালক
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    United KingdomBritish148654320001
    GREEN, Richard William
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    British121346530001
    GREENWAY, Anthony William
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202871130001
    HUDDART, Steven John
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    পরিচালক
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    EnglandEnglish191546760001
    JEANS, Roderick Manning
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    British50601570001
    JENKINS, John Michael
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    EnglandBritish115008010001
    KILLEEN, Gary Francis Paul
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    পরিচালক
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    EnglandEnglish81330540001
    LANGDON, Michael Robert Finch
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    পরিচালক
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    EnglandBritish1483050001
    LOMAS, Paul John
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish127596100001

    LEASECONTRACTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    ২৩ জুল, ২০১৯
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর1500252
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর3255766
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    LEASECONTRACTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £404,822.57 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date 7/6/95 contract no 1030474 vehicle hire agreement model vauxhall brava 2.5I a/c no 34. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £45,553.63 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements :- date 2.6.95 contract no 1030728 vehicle hire agreement model ford transit 2.5 regn no M289 yhj a/c/no 22. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £160,099.17 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £349,787.92 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights title and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £87,116.29 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £13,933.14 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £27,772.02 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12TH december 1994 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company assigns and charges to the bank by way of first fixed legal charge:- (I) all the benefits rights and title of the company in the contracts; and (ii) each and every motor vehicle from time to time subject of the contracts (the "motor vehicles"). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Singer & Friedlander Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Certificate of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements :- sub-hirer sony united kingdom limited ford mondeo 2OI glx h/back regn no M301 mpd. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sovereign Finances PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Certificate of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights benefits and interest present and future in and to sub-hire agreements made between various sub-hirers. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sovereign Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Certificate of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreemnts
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees :- customer no 021766 schedule no 000015 agreement no 01/308/01/513884 reg no M29 eea rover 214SE1 41 customer ref 1028472. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nws Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £222,479.54 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights title and interest of the company in the attached schedule contract no 1027675 agreement vehicle contract purchase reg no M217 odp make rover 2.0I. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £221,528.88 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights title and interest of the company in and under the agreements ,as specified in the schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements,all monies from time to time payable under any insurance payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £75,555.25 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under or pursuant to the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title and interest in and under the said agreements ,all monies now or hereafter to become payable under the agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all monies from time to time payable under the insurance in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £229,169.13 together with all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific charge over all the rights and interests of the company under the agreements specified in the schedule, all monies now or hereafter to become payable under the said agreements , the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all insurances payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Certificate of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreements
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nws Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Master assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agrements
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedules attached to the form 395 entered into pursuant to the master assignment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nws Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £359,353.33 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date-22.9.94, Contract no.-1025575, Type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-48, reg no-M113 xow, make/model-honda civic. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £135,919.45 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date-8.11.94, Contract no-1025865, type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-42, reg no-M108 njb, make/model-renault 19. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £36,467.67 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date-25.10.94, Contract no.-1026204, Type of agreement-schedule to master agreement, period of agt-12, reg no.-M791 jpf, make/model-rover 200 1.4I. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £58,680.10 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date-28.9.94, Contract no.-1026224, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-24, reg no.-L416 kto, make/model-vw passat. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £47,047.49 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date-18.10.94, Contract no-1026870, type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-28, reg no.-L753JCF, make/model-vauxhall frontera. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £270,688.25 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements date-9.11.94, Contract no.-1027231, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-36, reg no.-L688 sav, make/model-rover 600 2.01. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Master assignment and certificte of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights benefit and interest present and future in and 70 sub-hiring agreements :- ford granada 2.01 scorpio 4 dr saloon sin auto. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sovereign Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £107,344.53 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights and interests of the company under the agreements specified in the attached schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements. The vehicles comprised in and the subject of the said agreements as specified in the said schedule, and all monies from time to time payable under any insurance in respect of the said vehicles. The terms applicable to the charge agreement restrict the creation of any other charge whatsoever over the charged property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    LEASECONTRACTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১১ জুন, ২০২৪ভেঙে যাওয়ার কথা
    ২৬ সেপ, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0