ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01817913
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা কার্যক্রম (62090) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED১২ জুন, ২০০২১২ জুন, ২০০২
    AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED২১ মে, ১৯৮৪২১ মে, ১৯৮৪

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১২

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৩ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Thomson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ আগ, ২০১৩

    ২৭ আগ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ২৪ জুন, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    সচিব হিসাবে David William Hart Gray-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Gareth Wilson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    পরিচালক হিসাবে Adrian Stevens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ জুন, ২০১২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Adrian Charles Stevens-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Andrew James Edward Thomson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Gareth Antony Wilson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Mr Andrea Fiumicelli-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    সচিব
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357740001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishComputer Consultant17678130002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    সচিব
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    সচিব
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    সচিব
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    সচিব
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    British5361780001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    সচিব
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162045740001
    CLARKE, Robert Samuel
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishSales & Marketing44712370001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    পরিচালক
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    COWLES, Neil
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    পরিচালক
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    BritishDirector79753520001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director17678130002
    DAY, Robert William
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector66520250001
    EALES, Gillian Margaret
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    পরিচালক
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    BritishBusiness Administrator16296060001
    FRANKS, Nigel
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director39004110002
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    পরিচালক
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant178097680001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    পরিচালক
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    BritishDoctor5361780001
    MORRIS, Eamonn
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector65876940001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RAWCLIFFE, Richard William
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    BritishDirector86831530001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    পরিচালক
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    RICHARDS, Paul
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector82595090001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WATSON, Robert John
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director16296070002
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    পরিচালক
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৩ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০১ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee and Agent for the Lenders as Defined in the Facility Agreement)(the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0