CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01838150
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • (4525) /

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CONNAUGHT PROPERTY SERVICES LTD ০৫ জানু, ২০০০০৫ জানু, ২০০০
    CONNAUGHT GROUP LIMITED২৯ ডিসে, ১৯৯৯২৯ ডিসে, ১৯৯৯
    CONNAUGHT SOUTHERN LIMITED১১ মার্চ, ১৯৮৫১১ মার্চ, ১৯৮৫
    FORKRIVER LIMITED০৩ আগ, ১৯৮৪০৩ আগ, ১৯৮৪

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০০৯

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    20 পৃষ্ঠাLIQ14

    ০৪ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    24 পৃষ্ঠাLIQ03

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:notice of release of liquidator richard heis 22/1/18
    4 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    ০৪ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠাLIQ03

    আদালতের আদেশ দ্বারা লিকুইডেটর অপসারণ

    10 পৃষ্ঠাLIQ10

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    ০৪ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    25 পৃষ্ঠা4.68

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    INSOLVENCY:Secretary of State's Certificate of Release of Liquidator
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    একটি লিকুইডেটরের পদত্যাগ

    18 পৃষ্ঠা4.33

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order insolvency:C.O. To remove/replace liquidator
    11 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    একটি লিকুইডেটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠা4.33

    ০৪ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    21 পৃষ্ঠা4.68

    ০৪ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ০৮ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Kpmg 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB থেকে 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    ০৪ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠা4.68

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JONES, Peter
    34a Old Lane
    Nethertown, Drighlington
    BD11 1LU Bradford
    পরিচালক
    34a Old Lane
    Nethertown, Drighlington
    BD11 1LU Bradford
    United KingdomBritishDirector25379730002
    WELLS, David Francis
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishAccountant104366980002
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    সচিব
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146797250001
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    সচিব
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    HIDGLEY, Paul Frank
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX12 Axmouth Seaton
    Devon
    সচিব
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX12 Axmouth Seaton
    Devon
    British24801280001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    সচিব
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    BritishGroup Finance Director64426280002
    PHILLIPS, Jackey
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    সচিব
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British104367080003
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    সচিব
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    BritishChartered Accountant99914770001
    ANDREWS, Stephen
    1 Burleigh Park
    KT11 2DU Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    1 Burleigh Park
    KT11 2DU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector127799790001
    BRAY, Iain Richard
    198 Banbury Road
    CV37 7HX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    198 Banbury Road
    CV37 7HX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCommercial Director154064760001
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    পরিচালক
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    BritishAccountant47908530001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    পরিচালক
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    EnglandBritishManaging Director137575700001
    DAVIES, Mark Dingad
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector203044250004
    DUCKER, Jackie
    10 Avenue Road
    SO22 5AQ Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    10 Avenue Road
    SO22 5AQ Winchester
    Hampshire
    BritishDirector57381410002
    EVANS, Terence Mervin
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    পরিচালক
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    BritishDirector47913740001
    FLINT, Andrew Michael
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    পরিচালক
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    BritishDirector68436270001
    FLINT, Andrew Michael
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    পরিচালক
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    BritishSurveyor68436270001
    HANCOCK, Timothy John
    82 Argus Lofts
    Robert Street
    BN1 4AY Brighton
    East Sussex
    পরিচালক
    82 Argus Lofts
    Robert Street
    BN1 4AY Brighton
    East Sussex
    EnglandBritishDirector96124860001
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    পরিচালক
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director115233060001
    MIDGLEY, Paul Frank
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX14 4AJ Axmouth
    Devon
    পরিচালক
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX14 4AJ Axmouth
    Devon
    BritishContract Manager68851460001
    OLDBURY, Stephen James
    20 Stanley Avenue
    Chiswell Green
    AL2 3AB St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    20 Stanley Avenue
    Chiswell Green
    AL2 3AB St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director126379060001
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    পরিচালক
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritishChartered Accountant99914770001
    QUINN, Derek Anthony
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    পরিচালক
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    BritishSurveyor72848250001
    ROBERTS, Michael John
    Kibbear Cottage Kibbear
    Trull
    TA3 7LN Taunton
    Somerset
    পরিচালক
    Kibbear Cottage Kibbear
    Trull
    TA3 7LN Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishNational Sales Director66622050001
    SMITH, Richard David
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    পরিচালক
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    BritishCompany Director17374050001
    SPRIGINGS, Ian Campbell
    Mead Cottage Crowhurst Road
    Catsfield
    TN33 9BT Battle
    East Sussex
    England
    পরিচালক
    Mead Cottage Crowhurst Road
    Catsfield
    TN33 9BT Battle
    East Sussex
    England
    EnglandBritishQuantity Surveyor50610680001
    STANDING, Roger
    Broomwood Farmhouse
    Trolliloes Lane Cowbeech
    BN27 4QR Hailsham
    East Sussex
    পরিচালক
    Broomwood Farmhouse
    Trolliloes Lane Cowbeech
    BN27 4QR Hailsham
    East Sussex
    BritishDirector47913670002
    STEELE, Andrew Philip
    Westering
    8 Five Bells
    TA23 0HZ Watchet
    Somerset
    পরিচালক
    Westering
    8 Five Bells
    TA23 0HZ Watchet
    Somerset
    United KingdomBritishCommercial-Chartered Surveyor179702030008
    TINCKNELL, Angela
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    পরিচালক
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    BritishCompany Director24801290001
    TINCKNELL, Mark William
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    পরিচালক
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    EnglandBritishChairman4088810003
    TINCKNELL, William Charles
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    পরিচালক
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    BritishEngineering Director4088850001

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £20,204.92 (being equivalent of 3 months of the rents plus vat) or such greater sum (equivalent to 3 months of the rents plus vat from time to time).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Highgate Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Account legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All amounts sitting to the credit of account number 06025288. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ebury Contracting Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All the company's obligations to the bank of ceylon under a lease dated 7 august 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal charge the sum of £9,450 ("the deposit") standing to the credit of a deposit account in the bank's name at such clearing bank as it may in its absolute discretion determine.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Ceylon
    ব্যবসায়
    • ২১ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 6 pickering street armley leeds t/n wyk 295189. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from connaught group limited to the chargee on any account whatsoever under the provisions of the legal charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold property known as 109/111 east reech, taunton, somerset together with all fixtures and fittings and the benefit of all rights licences and the goodwill in relation to the business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    102 finlay road gloucester t/n gl 69467.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H, 16 tolworth rise south surbiton kingston-upon-thames greater london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 27A tradescent road, london SW8 title no sgl 440185.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ নভে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge on undertaking all property & assets present & future including bookdebts & uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৮ সেপ, ২০১০প্রশাসন শুরু
    ০৫ মার্চ, ২০১৩প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    David James Costley-Wood
    One Snow Hill Snow Hill Queensway
    B4 6GM Birmingham
    অভ্যাসকারী
    One Snow Hill Snow Hill Queensway
    B4 6GM Birmingham
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৫ মার্চ, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৫ মে, ২০২০ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    অভ্যাসকারী
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0