INSTORE.COM LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামINSTORE.COM LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01838445
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    INSTORE.COM LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    INSTORE.COM LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Trident Business Park
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    INSTORE.COM LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    EGH HOLDINGS LIMITED২৬ নভে, ১৯৮৪২৬ নভে, ১৯৮৪
    GLASSJUMP LIMITED০৬ আগ, ১৯৮৪০৬ আগ, ১৯৮৪

    INSTORE.COM LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৬

    INSTORE.COM LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৪ অক্টো, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৮ আগ, ২০১৭ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium a/c be reduced 25/07/2017
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Hemant Patel-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian York এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ নভে, ২০১৫

    ১৯ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,010
    SH01

    ২৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian York-এর নিয়োগ

    AP01

    ২৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Roy George Ellis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ অক্টো, ২০১৪

    ১৩ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,010
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ নভে, ২০১৩

    ১৯ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,010
    SH01

    ২৩ মে, ২০১৩ তারিখে Mr Abdul Aziz Tayub-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Mr Roy George Ellis-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ebrahim Suleman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01

    INSTORE.COM LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COLLINSON, Martin Donald
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    সচিব
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    British98796330005
    PATEL, Hemant
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    পরিচালক
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish104124100001
    TAYUB, Abdul Aziz
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    পরিচালক
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish16280660001
    HOLMES, Dennis
    17 Wynford Rise
    LS16 6HX Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    17 Wynford Rise
    LS16 6HX Leeds
    West Yorkshire
    British2136680001
    KEMP, Helen Anne
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    British48922660002
    LETHAM, Ian Ritchie
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    সচিব
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British9252900001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    সচিব
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SISSON, Hamish Paul
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    British43874820001
    BLISS, Henry Donald
    8 Cumberland Mills Square
    E14 3BH London
    পরিচালক
    8 Cumberland Mills Square
    E14 3BH London
    Canadian4094060001
    BROWN, Gary James
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    পরিচালক
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    EnglandBritish125196870001
    BURDON, Peter
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    পরিচালক
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    British70178470002
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    British103719400001
    DUFFY, Bryan Scott Alan
    Dane End House Dane End
    SG12 0LR Ware
    Herts
    পরিচালক
    Dane End House Dane End
    SG12 0LR Ware
    Herts
    EnglandBritish9252920001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    পরিচালক
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    ELLIS, Roy George
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    পরিচালক
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    WalesBritish161784490001
    GRAY, Ian
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    পরিচালক
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    British50246030002
    HAUGHTON, Townsend Andrew
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    South Africa39356840002
    REID, Charles Andrew
    The Pheasants Redland End
    Speen
    HP27 0RW Princes Risborough
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    The Pheasants Redland End
    Speen
    HP27 0RW Princes Risborough
    Buckinghamshire
    England
    British34631220001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    পরিচালক
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    SULEMAN, Ebrahim
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    EnglandBritish52733940001
    VISSER, Johan Jacobus
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    South African51820380002
    YORK, Ian
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    পরিচালক
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish197002910001

    INSTORE.COM LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Instore Group Limited
    Neptune Way, Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Neptune Way, Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland & Wales
    নিবন্ধন নম্বর02105209
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    INSTORE.COM LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nedcor Bank Limited as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৮ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • B & J Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of each or any of the finance documents (as defined) or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref M11C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank Plcthe "Security Agent" and the "Banks"
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on all goodwill and uncalled capital (see 395 for more details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুল, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts. Uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & all other debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £855,879 and all other monies due or to become due from e & g harris limited to the chargees on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Brown & Jackson PLC.
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0