T W PEARSON LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামT W PEARSON LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01854473
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    T W PEARSON LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7487) /

    T W PEARSON LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Firth House
    Meadowhall Road
    644
    S9 1JD Sheffield
    South Yorkshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    T W PEARSON LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    T. W. PEARSON FORGE LIMITED২৭ নভে, ১৯৮৪২৭ নভে, ১৯৮৪
    EACHTIME LIMITED১১ অক্টো, ১৯৮৪১১ অক্টো, ১৯৮৪

    T W PEARSON LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৯

    T W PEARSON LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    4 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৪ অক্টো, ২০১১ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ মার্চ, ২০১১

    ৩০ মার্চ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,800
    SH01

    ৩০ মার্চ, ২০১১ তারিখে Peter Simon Bland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে James Hart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Christopher David Seymour-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে James Hart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Christopher David Seymour-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ৩০ মার্চ, ২০১০ তারিখে James Thomas Hart-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ৩০ মার্চ, ২০১০ তারিখে Peter Simon Bland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩০ মার্চ, ২০১০ তারিখে James Thomas Hart-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    T W PEARSON LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SEYMOUR, Christopher David
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    সচিব
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    British158368840001
    BLAND, Peter Simon
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    পরিচালক
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant42351130005
    SEYMOUR, Christopher David
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    পরিচালক
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant158310680001
    ATKINSON, Mandy Elizabeth
    The Old School House
    Hopton Hall Lane
    WF14 8HP Mirfield
    West Yorkshire
    সচিব
    The Old School House
    Hopton Hall Lane
    WF14 8HP Mirfield
    West Yorkshire
    British56543190002
    BARKER, Michael Geoffrey
    115 Bawtry Road
    Wickersley
    S66 0BL Rotherham
    South Yorkshire
    সচিব
    115 Bawtry Road
    Wickersley
    S66 0BL Rotherham
    South Yorkshire
    British11670350001
    GIBBONS, Michael Andrew
    9 Garth Way
    S18 1RL Dronfield
    Derbyshire
    সচিব
    9 Garth Way
    S18 1RL Dronfield
    Derbyshire
    British60763380001
    HAGUE, Roger Pearson
    Brown Hills Farm Brown Hills Lane
    Fulwood
    S10 4PE Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    Brown Hills Farm Brown Hills Lane
    Fulwood
    S10 4PE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director11670370001
    HART, James Thomas
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant115557140002
    KEIGHLEY, Richard Nicholas
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    সচিব
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    British137305900001
    RILEY, Michelle
    12 Sparrowbusk Close
    Barlborough
    S43 4UT Chesterfield
    Derbyshire
    সচিব
    12 Sparrowbusk Close
    Barlborough
    S43 4UT Chesterfield
    Derbyshire
    British48089610002
    AINSWORTH, Sydney
    Highway Derwent Lane
    Hathersage Hope Valley
    S32 1AS Sheffield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Highway Derwent Lane
    Hathersage Hope Valley
    S32 1AS Sheffield
    Derbyshire
    BritishEngineer56543130001
    BARKER, Michael Geoffrey
    115 Bawtry Road
    Wickersley
    S66 0BL Rotherham
    South Yorkshire
    পরিচালক
    115 Bawtry Road
    Wickersley
    S66 0BL Rotherham
    South Yorkshire
    BritishCost & Management Accountant11670350001
    BERGIN, John Charles Michael Francis
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishExecutive12452990001
    BIGGIN, Terrence
    27 The Grove
    Loxley
    S6 6RE Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    27 The Grove
    Loxley
    S6 6RE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector11688890001
    FOWLER, Ralph
    Skiers View
    Meadowfield Drive Hoyland
    S74 0QE Barnsley
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Skiers View
    Meadowfield Drive Hoyland
    S74 0QE Barnsley
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector11670380002
    HAGUE, Jose
    Durbrooks Horsley Gate Lane
    Holmesfield
    S18 5WD Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Durbrooks Horsley Gate Lane
    Holmesfield
    S18 5WD Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector16617360001
    HAGUE, Roger Pearson
    Brown Hills Farm Brown Hills Lane
    Fulwood
    S10 4PE Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Brown Hills Farm Brown Hills Lane
    Fulwood
    S10 4PE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChairman11670370001
    HALL, David John
    Craglands
    Ashopton Road, Bamford
    S33 0DB Hope Valley
    Derbyshire
    পরিচালক
    Craglands
    Ashopton Road, Bamford
    S33 0DB Hope Valley
    Derbyshire
    BritishCompany Director40070600001
    HART, James Thomas
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant115557140002
    KIRKHAM, Philip David
    Lime Spinney Somersall Close
    Somersall
    S40 3SG Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Lime Spinney Somersall Close
    Somersall
    S40 3SG Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector & General Manager13484340002
    MACDONALD, Neil Andrew
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director3696630003
    PEARSON HAGUE, Peter
    Durbrooks Horsley Gate Lane
    Holmesfield
    S18 5WD Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Durbrooks Horsley Gate Lane
    Holmesfield
    S18 5WD Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector16589730001
    RILEY, Michelle
    12 Sparrowbusk Close
    Barlborough
    S43 4UT Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    12 Sparrowbusk Close
    Barlborough
    S43 4UT Chesterfield
    Derbyshire
    BritishCompany Director48089610002
    TOWNEND, John Neville
    14 Meadowfield Drive
    Hoyland
    S74 0QE Barnsley
    South Yorkshire
    পরিচালক
    14 Meadowfield Drive
    Hoyland
    S74 0QE Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector47257340001

    T W PEARSON LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all properties listed in schedule with all buildings and fixtures thereon and by way of first equitable charge over all subsidiary shares,investments and all distribution rights and all freehold/leasehold property not charged pursuant to clause 2.3(a) of the deed; all book debts,rights and claims,all monetary claims and monies standing to the credit of its accounts; the goodwill and uncalled capital; floating charge over all assets; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London,as Security Trustee for Itself and Theother Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 290/292 and adjoining premises penistone road sheffield south yorkshire t/no.SYK711 and SYK27288 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific equitable charge over all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over goodwill & book debts. Legal mortgage over f/h land owleton bridge street works peristone road, sheffield, S. yorks and/or the proceeds of sale thereof.. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    T W PEARSON LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ এপ্রি, ২০১২ভেঙে গেছে
    ০৪ অক্টো, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0