QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামQUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01868770
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    QUORUM INVESTMENTS LIMITED১০ আগ, ২০০১১০ আগ, ২০০১
    QUORUM ESTATES LIMITED০৫ ডিসে, ১৯৮৪০৫ ডিসে, ১৯৮৪

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ অক্টো, ২০১৬

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    14 পৃষ্ঠাLIQ13

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাNDISC

    ০৮ অক্টো, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    15 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৭ নভে, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT থেকে Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TAপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    6 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৯ অক্টো, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ অক্টো, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 018687700074 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 018687700075 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 018687700076 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    Paul Dominic Cook কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    5 পৃষ্ঠাRP04AP01

    ৩১ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 018687700077 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 018687700078 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ জানু, ২০১৬

    ০৪ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 20,502
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed quorum investments LIMITED\certificate issued on 04/03/15
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৭ ফেব, ২০১৫

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ জানু, ২০১৫

    ০৫ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 20,502
    SH01

    চার্জ নিবন্ধন 018687700078

    32 পৃষ্ঠাMR01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৭ জুন, ২০১৪This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    চার্জ নিবন্ধন 018687700077

    42 পৃষ্ঠাMR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WARDLE, Katharine Jane
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    149162780001
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর7038430
    146358090001
    COOK, Paul Dominic
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor181927220001
    SLATER, John David
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director6240010001
    WARDLE, Paul Martin
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCo Director25540580004
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    সচিব
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    SLATER, Ann Christine
    Tudor Cottage, 14 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    Tudor Cottage, 14 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    British43958640001
    OGLESBY, Michael John
    Moss Farm
    South Downs Road
    WA14 3DR Bowdon
    Cheshire
    পরিচালক
    Moss Farm
    South Downs Road
    WA14 3DR Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director148307320001

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ৩১ ডিসে, ২০১৬কোম্পানি এখনও কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত একজন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা একটি নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করেনি

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুন, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 79 and 81 dane road sale t/no GM430829.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুন, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ সেপ, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ সেপ, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that leasehold property known as unit 2, clarke industrial estate, barton dock road, stretford. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১২ এপ্রি, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১২ এপ্রি, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 2 clarke industrial estate, barton dock road, stretford, title numbers GM221602 and GM936233. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১২ এপ্রি, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H block 16 sharston industrial estate manchester.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H block 16 sharston industrial estate manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from quorum developments limited ot the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a land and buildings at the oakfield centre langley lane northenden t/n GM433353. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter and/or in connection with the facility granted and/or under the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific charge all the income and rights relating thereto from time to time arising or payable to or on behalf of the mortgagor in relation to the property and the proceeds of any sale, lease or other disposition in respect thereof and all deeds and documents from time to time relating and all insurance and compensation monies as defined in the legal charge. Floating charge all movable plant machinery implements, building materials of all kinds utensils and equipment belonging to the mortgagor.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a the oakfield centre longley lane harling road northenden greater manchester t/n GM433353. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £75,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H plot of land at the industrial estate winsford containing 5.72 acres or thereabouts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nash Europe Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings road one winsford industrial estate winsford cheshire specific charge all income rights proceeds of sale all deeds insurance and compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N M Rothschild & Sons Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The towers towers business park wilmslow road didsbury manchester M20 2SL specific charge all income rights proceeds of sale all deed insurance compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N M Rothschild & Sons Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a shirley towers didsbury greater manchester t/no.GM486813 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £75,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Shirley towers didsbury manchester t/no.GM486813.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Textile Technology Group
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 9TH may 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    71/75 (odd) jameson street, kingston upon hull, humberside t/no. HS233356. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N M Rothschild & Sons Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land on the east side of ripon road killinghall harrogate west yorkshire k/a crofters green t/n NYK157806 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land and buildings on the north east and south west sides grimshaw lane middleton lancashire k/a the linkway estate t/n LA115001 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The monies and liabilities secured by a legal charge in favour of hill samuel bank limited as agent and trustee for the banks (as defined in the legal charge)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All present and future rights and interests which the company may have in abney hall and abney court,manchester road,cheadle,stockport,greater manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The monies and liabilities secured by a legal charge in favour of hill samuel bank limited as agent and trustee for the banks and lending institutions
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All present or future rights and interests which the company may have in abney hall and abney court,manchester road,cheadle,stockport,greater manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 11TH february 1994
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the property formerly comprising part of the white house hotel jameson street kingston upon hull.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Stewart Rogerson
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of debt
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £652,335.65 due from the royal bank of scotland (I.O.M.) limited to the company including all interest accrued or accruing in the future on the amount of the debt and all increases in the amount of the debt.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any associated company or any guarantor (as defined in the legal charge) to united dominions trust limited o any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land on the east side of bredbury park way bredbury stockport greater manchester t/n GM494884 all and any proceeds of the property,all value added tax,the benefit of all licences ,all insurance policies and agreements connected with the property (see form 395 and continuation sheets for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • United Dominions Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the estate interest right whatsoever of the company under an agreement dated 2ND june 1989 and all monies payable thereunder (for full details see form 395 and continuation sheets).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • United Dominions Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balance
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 31ST march 1992
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of one million one hundred and sixteen thousand two hundred and thirtythree pounds eighty three pence on an account numbered 66539901 held by the bank with reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • County Natwest
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৯ অক্টো, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৯ মার্চ, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Steve Markey
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    অভ্যাসকারী
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Martin Maloney
    Leonard Curtis House 1a Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Manchester
    অভ্যাসকারী
    Leonard Curtis House 1a Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0