SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01869628
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HAZELBARON LIMITED০৭ ডিসে, ১৯৮৪০৭ ডিসে, ১৯৮৪

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৯ সেপ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    পরিচালক হিসাবে Mr Paul Antony Woolf-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Norman Field এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ আগ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Matthew Graham Merrick-এর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৭ সেপ, ২০১১The form is a duplicate of AP01 registered on 12/09/2011

    সচিব হিসাবে James Archibald-এর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠাAP03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৭ সেপ, ২০১১The form is a duplicate of AP03 registered on 12/09/2011

    সচিব হিসাবে James Archibald-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Matthew Graham Merrick-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    সচিব
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162966780001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    পরিচালক
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishCompany Director162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    পরিচালক
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishUk Finance Director162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    পরিচালক
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishDirector160679880001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    সচিব
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    British46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    সচিব
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    BritishAccountant58961410002
    DAND, Elizabeth Marie
    43 Montague Road
    TW10 6QJ Richmond
    Surrey
    সচিব
    43 Montague Road
    TW10 6QJ Richmond
    Surrey
    BritishFinancial Controller35024770001
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    সচিব
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    PENRICE, Victoria Margaret
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    সচিব
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    British90459300001
    RADIN, Richard
    8 Abbotsbury Road
    W14 8EJ London
    সচিব
    8 Abbotsbury Road
    W14 8EJ London
    British3574810001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    সচিব
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    সচিব
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    BritishChartered Secretary66825690001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    সচিব
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WHEELER, Jonathan
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    সচিব
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    British19812400001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    সচিব
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    BritishChartered Secretary123616460002
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    পরিচালক
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    EnglandBritishAccountant46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    পরিচালক
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Ntant58961410002
    BAXTER, Headley Thomas
    8 York House Courtlands
    Sheen Road
    Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    8 York House Courtlands
    Sheen Road
    Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director3574820001
    BAXTER, Susan Marion Fraser
    8 York House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5BD Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    8 York House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5BD Richmond
    Surrey
    BritishAccountant38716650001
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    পরিচালক
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    BritishDirector80515670001
    BECKWITH, Peter Michael
    29 Marryat Road
    SW19 London
    পরিচালক
    29 Marryat Road
    SW19 London
    BritishDirector44336530001
    BERNARD, Maxime Douglas Theobald
    37 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    পরিচালক
    37 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    FrenchManager38716580001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    পরিচালক
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant12337010002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    পরিচালক
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritishCompany Director3716600001
    DAND, Elizabeth Marie
    Rythebrook House 17 Princes Drive
    KT22 0UL Oxshott
    Surrey
    পরিচালক
    Rythebrook House 17 Princes Drive
    KT22 0UL Oxshott
    Surrey
    BritishFinancial Controller35024770003
    DHODY, Jog
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    FIELD, Norman Mark
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth AfricanCompany Director161860310001
    FOSTER, Michael Raymond
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    পরিচালক
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    EnglandBritishChartered Accountant53280440001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    পরিচালক
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Esporta Group69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    পরিচালক
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director, Esporta G100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    HENCHOZ, Patrick
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    পরিচালক
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    United KingdomSwissDirector93431850001
    HUTCHINS, Paul Raymond
    6 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    পরিচালক
    6 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    United KingdomBritishManaging Director14450450001

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement dated 9TH september 1993 and supplemental to a guarantee and debenture dated 5TH november 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the books of the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Premises at hannibal way roundshaw sutton.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Lawn Tennis Association
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property known as fort of roundshaw playing fields in the london borough of sutton. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুল, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a building agreement dated 18/2/85
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific charge of all the companys benefit in the building agreement and its estate or interest from time to time in the hereditaments and property comprised in the building agreement howsoever arising or subsisting relating to land situate at hanibal way, roundshaw sutton, surrey.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুল, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৪ সেপ, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২০ নভে, ২০১৪ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    অভ্যাসকারী
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0