DTF REALISATIONS (2012) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDTF REALISATIONS (2012) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01908417
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6523) /

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DAVENHAM TRADE FINANCE LIMITED১৮ ফেব, ১৯৯১১৮ ফেব, ১৯৯১
    BURNS-ANDERSON TRADE FINANCE LIMITED৩১ মে, ১৯৮৮৩১ মে, ১৯৮৮
    B A TRADE FINANCE LIMITED১৭ জুন, ১৯৮৫১৭ জুন, ১৯৮৫
    REAPCROSS LIMITED২৫ এপ্রি, ১৯৮৫২৫ এপ্রি, ১৯৮৫

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১০

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order insolvency:form 2.39B and court order
    14 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    ১১ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    36 পৃষ্ঠা2.24B

    ১১ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    36 পৃষ্ঠা2.35B

    ১৬ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    39 পৃষ্ঠা2.24B

    ২৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    41 পৃষ্ঠা2.24B

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed davenham trade finance LIMITED\certificate issued on 04/03/13
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২১ নভে, ২০১২

    RES15

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২১ নভে, ২০১২

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ৩১ আগ, ২০১২ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    46 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৩ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    46 পৃষ্ঠা2.24B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    5 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    91 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    77 পৃষ্ঠা2.17B

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ০২ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Rodier Kerr-Muir-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ ফেব, ২০১১

    ২৪ ফেব, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে David Coates এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০৯ ফেব, ২০১০ তারিখে Qconsult Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    QCONSULT LIMITED
    173 Chorley New Road
    BL1 4QZ Bolton
    Laurel House
    Lancashire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    173 Chorley New Road
    BL1 4QZ Bolton
    Laurel House
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর4884956
    137685820001
    BURKE, Paul
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    পরিচালক
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    United KingdomBritishDirector104461630001
    KERR-MUIR, James Rodier
    Deansgate
    Camp Street
    M3 4JB Manchester
    274
    Manchester
    United Kingdom
    পরিচালক
    Deansgate
    Camp Street
    M3 4JB Manchester
    274
    Manchester
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director163887670001
    HAMLYN, John Michael
    Stoneridge Cottage Green Lane
    Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    সচিব
    Stoneridge Cottage Green Lane
    Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    British55749820002
    SMETHURST, Dawn Elizabeth
    5 Pheasant Walk
    High Legh
    WA16 6LU Knutsford
    Cheshire
    সচিব
    5 Pheasant Walk
    High Legh
    WA16 6LU Knutsford
    Cheshire
    BritishManager58471810001
    BAYES, Maurice Arthur
    25 The Avenue
    SM2 7QA Sutton
    Surrey
    পরিচালক
    25 The Avenue
    SM2 7QA Sutton
    Surrey
    BritishBanker43642070001
    BOWLES, David
    2 Yarra Court
    Gildersome Morley
    LS27 7LA Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    2 Yarra Court
    Gildersome Morley
    LS27 7LA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector120417090001
    BRIERLEY, David
    13 Strawberry Hill Drive
    Paget Pg 05
    FOREIGN Bermuda
    পরিচালক
    13 Strawberry Hill Drive
    Paget Pg 05
    FOREIGN Bermuda
    CanadianBanker60105890001
    BROOKS, Graham Corby
    23 Mount Wyndham Drive
    Hamilton Parish
    Cro4
    Bermuda
    পরিচালক
    23 Mount Wyndham Drive
    Hamilton Parish
    Cro4
    Bermuda
    BritishBanker74509600001
    COATES, David Raiffe
    8 St John Street
    Manchester
    M3 4DU
    পরিচালক
    8 St John Street
    Manchester
    M3 4DU
    EnglandBritishDirector103580860001
    DAVENPORT, Colin
    19a Tanhouse Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Lancashire
    পরিচালক
    19a Tanhouse Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director52877220001
    DIGGINES, Jonathan Brett
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    পরিচালক
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    BritishDirector80119110001
    FARLEY, Henry Edward
    Sylvan Lodge
    Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Sylvan Lodge
    Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director75054860003
    FERRETT, Richard John
    Wistowe
    21 North Shore Road
    Hamilton Parish
    Fl04
    Bermuda
    পরিচালক
    Wistowe
    21 North Shore Road
    Hamilton Parish
    Fl04
    Bermuda
    BritishBanker65960600001
    GOOM, Roderick John
    Cote D Azur
    5 Prospero Lane
    FL 08 Knapton Hill
    Smiths
    Bermuda
    পরিচালক
    Cote D Azur
    5 Prospero Lane
    FL 08 Knapton Hill
    Smiths
    Bermuda
    BritishBanker52821370003
    HAIGH, David William
    Well House Hook Heath Road
    GU22 0LF Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Well House Hook Heath Road
    GU22 0LF Woking
    Surrey
    BritishBanker15163170001
    HAMLYN, John Michael
    Stoneridge Cottage Green Lane
    Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Stoneridge Cottage Green Lane
    Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant55749820002
    HASTED, Charles Vernon
    2 Garth Heights
    Wilmslow Park North
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    2 Garth Heights
    Wilmslow Park North
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishDirector83873510001
    JOHNSTON, Malcolm Carlyle Calum
    B5 3 Queens Cove
    Pembroke
    Hm 05
    Bermuda
    পরিচালক
    B5 3 Queens Cove
    Pembroke
    Hm 05
    Bermuda
    British CanadianBanker74796290001
    LEACH, Ruth
    19 Grains Road
    Shaw
    OL2 8HZ Oldham
    Lancashire
    পরিচালক
    19 Grains Road
    Shaw
    OL2 8HZ Oldham
    Lancashire
    BritishManager58471800002
    MARSH, Steven Robert
    156 Chester Road
    Hazel Grove
    SK7 6HE Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    156 Chester Road
    Hazel Grove
    SK7 6HE Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishBanker21400080002
    NEWTON, Paul Michael
    Over Hall Farm
    Flag Lane
    PR26 9AD Bretherton
    Lancashire
    পরিচালক
    Over Hall Farm
    Flag Lane
    PR26 9AD Bretherton
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector109730120001
    SHARP, William Drummond
    Norwood 12 A Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    Norwood 12 A Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector2841420001
    SHORE, Wayne
    49 Chatsworth Road
    S17 3QG Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    49 Chatsworth Road
    S17 3QG Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker89240700001
    TRIPPIER, David Austin, Sir
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    BritishDirector27871400001
    WISE, Raymond
    116 Moss Lane
    M33 5BH Sale
    Cheshire
    পরিচালক
    116 Moss Lane
    M33 5BH Sale
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector70672960001

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other creditors (or any of them) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become from the chargors to the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 8/8A st john street t/no. GM96521, the f/h property k/a 16 longworth street t/no. LA352072 and the l/h property k/a premises on 2ND floor, 274 deansgate, manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities whatsoever of each charging company (as defined) to the chargee, as security trustee for the beneficiaries (as defined) under the facility documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    DTF REALISATIONS (2012) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১১ এপ্রি, ২০১৩প্রশাসন শেষ
    ১৪ অক্টো, ২০১১প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David John Whitehouse
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Matthew Peter Bond
    Duff & Phelps Ltd 43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    অভ্যাসকারী
    Duff & Phelps Ltd 43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Phillip Francis Duffy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0