FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01909445
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    FAIRBRIAR DEVELOPMENTS LIMITED০৩ জুন, ১৯৯৬০৩ জুন, ১৯৯৬
    FAIRBRIAR INVESTMENTS LIMITED০৪ সেপ, ১৯৮৫০৪ সেপ, ১৯৮৫
    SWANMIGHT LIMITED২৯ এপ্রি, ১৯৮৫২৯ এপ্রি, ১৯৮৫

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১০

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    সচিব হিসাবে Valsec Company Secretarial Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ জুন, ২০১১

    ১৬ জুন, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 101
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Removal of share capital 23/12/2010
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Sect 551 ca 2006 23/12/2010
    RES13

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed fairbriar developments LIMITED\certificate issued on 19/01/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৯ জানু, ২০১১

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    CONNOT

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৩ ডিসে, ২০১০

    RES15

    ২৩ ডিসে, ২০১০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    3 পৃষ্ঠাSH01

    সচিব হিসাবে Valad Secretarial Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Valsec Company Secretarial Services Limited-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP04

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২২ মে, ২০১০ তারিখে Valad Secretarial Services Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Dr Stanley Swee Han Quek-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Simon John Patrick Lear-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288c

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    সচিব
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    British90211410001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    পরিচালক
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    পরিচালক
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    সচিব
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    সচিব
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    STAFFORD, Rodney Frank John
    8a The Glade
    KT22 9TH Fetcham
    Surrey
    সচিব
    8a The Glade
    KT22 9TH Fetcham
    Surrey
    British34094600001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    সচিব
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    কর্পোরেট সচিব
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    কর্পোরেট সচিব
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর7307485
    154199770001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    পরিচালক
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    COOMBES, William Frederick
    Windles
    Bangor Road North
    LL57 Ivor Heath
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Windles
    Bangor Road North
    LL57 Ivor Heath
    Buckinghamshire
    British18604620001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    পরিচালক
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    HANKINSON, Derek William
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    British822380001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    পরিচালক
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PAIRMAN, Lynda Annette
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    পরিচালক
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    British132910006
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    পরিচালক
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    WOOD-PENN, Richard Cecil
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish99981260001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property being part of the land comprised in title no. K555760. fixed charges on all buildings and other structures on the property, any goodwill, all plant machinery and other items affixed to the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. Assignment of the rental sums. Floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or at the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ফেব, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the beneficial interest in relation to the f/h property situate at and k/a home farm home farm lane tunbridge wells kent t/n k 446173.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৯০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0