IN BUSINESS MEDIA LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামIN BUSINESS MEDIA LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01921874
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Trelawney House
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ATALINK PUBLISHING LIMITED১৭ আগ, ২০১১১৭ আগ, ২০১১
    PRETEND LIMITED১৫ সেপ, ২০০৯১৫ সেপ, ২০০৯
    ATALINK PUBLISHING LIMITED২৮ জুল, ১৯৯৮২৮ জুল, ১৯৯৮
    ATALINK LIMITED১২ জুন, ১৯৮৫১২ জুন, ১৯৮৫

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৩

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ ফেব, ২০১৪

    ২৬ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14,816
    SH01

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ মার্চ, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Derek Alexander Morren এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ০৯ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adrian James Dunleavy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ১০ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Derek Alexander Morren-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Adrian James Dunleavy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Mckerlie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alex Connock এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed atalink publishing LIMITED\certificate issued on 17/01/12
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৭ জানু, ২০১২

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৭ জানু, ২০১২

    RES15

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed pretend LIMITED\certificate issued on 17/08/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৭ আগ, ২০১১

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৭ আগ, ২০১১

    RES15

    ২৩ ফেব, ২০১১ তারিখে Ten Alps Plc-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH02

    পরিচালক হিসাবে Andrew Mckerlie-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    পরিচালক হিসাবে Ten Alps Plc-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    ২১ ফেব, ২০১১ তারিখে Mr Nitil Patel-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ২১ ফেব, ২০১১ তারিখে Mr Nitil Patel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PATEL, Nitil
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    BritishFinancial Director126644210001
    PATEL, Nitil
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Director126644210001
    CLARKE, Nancy Louise
    1 Milton Avenue
    N6 5QF London
    সচিব
    1 Milton Avenue
    N6 5QF London
    British9692290001
    HUTCHINGS, Christopher
    4 Flagstaff Close
    EN9 1JB Waltham Abbey
    Essex
    সচিব
    4 Flagstaff Close
    EN9 1JB Waltham Abbey
    Essex
    British33877510002
    MOSS, Graeme John
    60 Meadow Walk
    Ewell
    KT17 2ED Epsom
    Surrey
    সচিব
    60 Meadow Walk
    Ewell
    KT17 2ED Epsom
    Surrey
    BritishCompany Secretary8175050001
    DUNLEAVY, Adrian James
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer112236910001
    DUNLEAVY, Adrian James
    Roundstone House
    WA14 3RG Millington
    Cheshire
    পরিচালক
    Roundstone House
    WA14 3RG Millington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director112236910001
    FENTON, Stephen Kenneth
    Flat 5 Regent Court
    279 Kingsland Road Hackney
    E2 London
    পরিচালক
    Flat 5 Regent Court
    279 Kingsland Road Hackney
    E2 London
    BritishDirector9692310001
    GREGORIOU, Charles
    1 Creighton Avenue
    Muswell Hill
    N10 1NX London
    পরিচালক
    1 Creighton Avenue
    Muswell Hill
    N10 1NX London
    BritishDirector41031020002
    HEMPENSTALL, Thomas
    12 Pine Hill
    KT18 7BG Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    12 Pine Hill
    KT18 7BG Epsom
    Surrey
    BritishDirector119534520001
    MORREN, Derek Alexander
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Chestergate
    SK11 6DW Macclesfield
    Trelawney House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director114001580004
    MORREN, Derek Alexander
    Ashwood Farm Court
    Wervin
    CH2 4HF Chester
    3
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ashwood Farm Court
    Wervin
    CH2 4HF Chester
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector114001580002
    VINCENT, Paul Stephen
    Sunway Beech Drive
    Kingswood
    KT20 6PS Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    Sunway Beech Drive
    Kingswood
    KT20 6PS Tadworth
    Surrey
    BritishDirector8175090001
    ALEX CONNOCK
    15 Links Place
    EH6 7EZ Edinburgh
    Great Michael House
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    15 Links Place
    EH6 7EZ Edinburgh
    Great Michael House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSC075133
    158003440002
    ANDREW MCKERLIE
    Links Place
    EH6 7EZ Edinburgh
    Great Michael House
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Links Place
    EH6 7EZ Edinburgh
    Great Michael House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSC075133
    158003610001
    METAL BULLETIN PLC
    Park House
    Park Terrace
    KT4 7HY Worcester Park
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    Park House
    Park Terrace
    KT4 7HY Worcester Park
    Surrey
    83597810001

    IN BUSINESS MEDIA LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any right title or interest in or to any credit balance being any sum standing to the credit of the account, whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২০ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুন, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0