MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMALTHUS INSTRUMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01926410
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PULSEGLOW LIMITED২৭ জুন, ১৯৮৫২৭ জুন, ১৯৮৫

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০১৫

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Steven Quinlan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ অক্টো, ২০১৫

    ২০ অক্টো, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 600,000
    SH01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Lamar Herbert-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Gareth Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Paul Gareth Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Colin Goodwille এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Maclaren Cassells এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Leslie Morris এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Jeffrey Irwin Holmes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ অক্টো, ২০১৪

    ২৩ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 600,000
    SH01

    ২৩ অক্টো, ২০১৪ তারিখে Colin Goodwille-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Mr Ian Leslie Morris-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Paul Gareth Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mr Paul Gareth Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Mark Sullivan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ অক্টো, ২০১৩

    ০২ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 600,000
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Dr John Maclaren Cassells-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HERBERT, James Lamar
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican200649010001
    HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish200627160001
    QUINLAN, Steven
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican203110190001
    BROWN, Michael Stewart
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    সচিব
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    British86327240001
    COTTON, Angela
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    সচিব
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    British62018140001
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    সচিব
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    সচিব
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    JAMES, Richard David
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    সচিব
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    British80458850001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    7 St Johns Court
    Lees
    OL4 3LN Oldham
    Lancashire
    সচিব
    7 St Johns Court
    Lees
    OL4 3LN Oldham
    Lancashire
    British49723980001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    সচিব
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    British3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    সচিব
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    184024770001
    SULLIVAN, Mark James
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    সচিব
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    British101060960001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    38962110003
    HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    900002670001
    ADLER, Alan William
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    পরিচালক
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Citizen Of Usa3856820001
    BONDSWELL, Andrew
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British62729310001
    BOWHILL, Keith Nicholas
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    British61679460002
    BUHL, Christian
    Noddegangen 9
    FOREIGN Holte Dk 2840
    Denmark
    পরিচালক
    Noddegangen 9
    FOREIGN Holte Dk 2840
    Denmark
    Danish30528580001
    CASSELLS, John Maclaren, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish63881080001
    GOODWILLE, Colin
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Colin
    The Old Rectory Church Lane
    Papworth Everard
    CB3 8QN Cambridge
    পরিচালক
    The Old Rectory Church Lane
    Papworth Everard
    CB3 8QN Cambridge
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Fiona Ford
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    পরিচালক
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    British20914960001
    GRNNING, Torben Guth
    Flat 3
    36 Montagu Square
    W1H 1TL London
    পরিচালক
    Flat 3
    36 Montagu Square
    W1H 1TL London
    Danish18303130001
    GUNLACK, Robert Henry
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    পরিচালক
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish27971040006
    HILLARY, Alan
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    পরিচালক
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish13184060001
    KERTON, Nicholas Anthony, Dr
    Brambles Oakfield
    Hawkhurst
    TN18 4JR Cranbrook
    Kent
    পরিচালক
    Brambles Oakfield
    Hawkhurst
    TN18 4JR Cranbrook
    Kent
    British59321720001
    MORRIS, Ian Leslie
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish138377860001
    PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    EnglandBritish17972160001
    SCHRODER, Johan
    Christiansholms
    Parallelvej 15 Dk-2930 Klampenborg
    Denmark
    পরিচালক
    Christiansholms
    Parallelvej 15 Dk-2930 Klampenborg
    Denmark
    Danish3856860001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish187422070001
    STAMMERS, Brian Michael, Dr
    9 Farley Way
    MK43 7QL Stevington
    Bedfordshire
    পরিচালক
    9 Farley Way
    MK43 7QL Stevington
    Bedfordshire
    British98198380001
    SYMS, Allan, Dr
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    পরিচালক
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    British128513480001
    WALPOLE, Malcolm William
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    পরিচালক
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    British107822300001

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over a deposit held by yorkshire bank PLC (own account)
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Yorkshire bank PLC current account no: 68162730 account name: malthus instruments limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £16,500.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J. Sainsbury Trustees Limited and J Sainsbury Trustees (No.2) Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0