IMEX SPACES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামIMEX SPACES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01931478
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    IMEX SPACES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    IMEX SPACES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    IMEX SPACES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    I-MEX PROPERTIES LTD২৩ মে, ১৯৮৯২৩ মে, ১৯৮৯
    DOVEARCH LIMITED১৮ জুল, ১৯৮৫১৮ জুল, ১৯৮৫

    IMEX SPACES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৯

    IMEX SPACES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৮ সেপ, ২০১০ তারিখে

    LRESSP

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    পরিচালক হিসাবে Philip Warner এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    resolution

    নির্বাচনী প্রস্তাব

    ELRES

    IMEX SPACES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    সচিব
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    পরিচালক
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrishChartered Accountant62140690001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    পরিচালক
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritishAccountant5689250001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector45345090004
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    সচিব
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    NORRIS, Patricia Pamela
    Flat 6 Broadlands Lodge
    Broadlands Road Highgate
    N6 4AW London
    সচিব
    Flat 6 Broadlands Lodge
    Broadlands Road Highgate
    N6 4AW London
    British4318800001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    সচিব
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    BritishCompany Director78391680002
    ARONSOHN, Norman Edward
    1 Ardwick Road
    NW2 2BX London
    পরিচালক
    1 Ardwick Road
    NW2 2BX London
    United KingdomBritishCompany Director6647720001
    BETTS, David Richard
    Apartment 58
    Ragged Staff Wharf
    Queensway
    Gibraltar
    পরিচালক
    Apartment 58
    Ragged Staff Wharf
    Queensway
    Gibraltar
    SpainBritishDirector80803300001
    CHAPMAN, Robert William Thomas
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director32652350001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant26086560001
    CRAN, William Michael
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director5206400002
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    পরিচালক
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector78151560001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishDirector45345090004
    GLEGHORN, Keith William
    Royd Top Broad Lane
    Upperthong Holmfirth
    HD7 1LS Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Royd Top Broad Lane
    Upperthong Holmfirth
    HD7 1LS Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector43071440002
    GOULD, Bernard David
    76 Woodhill Crescent
    Kenton
    HA3 0LZ Harrow
    Middlesex
    পরিচালক
    76 Woodhill Crescent
    Kenton
    HA3 0LZ Harrow
    Middlesex
    BritishCompany Director4021030001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    পরিচালক
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    BritishChartered Surveyor85468580002
    HERRITTY, Jayne
    17 Paradise Lane
    Hall Green
    B28 0DY Birmingham
    পরিচালক
    17 Paradise Lane
    Hall Green
    B28 0DY Birmingham
    BritishMarketing Director45641090001
    HINE, Derek Leslie
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    পরিচালক
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    BritishManaging Director29871470001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishDirector10146340003
    KIRKWOOD, Stuart Watson
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    BritishDirector76937270002
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    পরিচালক
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    EnglandBritishAccountant5785520001
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishProperty Investment Director73793650001
    SALMON, Steven Kenneth
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishGroup Finance Director66565200002
    SHERRATT, Peter John
    23 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LD Birmingham
    পরিচালক
    23 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LD Birmingham
    BritishCompany Director52526530002
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    পরিচালক
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritishDirector32981540001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor60348780002
    STEVENSON, Roland
    24 Miranda Drive
    Heathcote
    CV34 6FE Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    24 Miranda Drive
    Heathcote
    CV34 6FE Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector1160500003
    STOKES, Thomas Mcnair
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    পরিচালক
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishDirector854380001
    TAYLOR, Margaret
    15 Capesthorne Close
    Holmes Chapel
    CW4 7EN Crewe
    Cheshire
    পরিচালক
    15 Capesthorne Close
    Holmes Chapel
    CW4 7EN Crewe
    Cheshire
    BritishDirector64610720001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    পরিচালক
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    BritishCompany Director78391680002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Chief Executive7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector68256540001

    IMEX SPACES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Colville business centre, goliath way, hermitage estate, colville t/n LT300425 south side of waingate, lower clough, linthwaite, hudderfield t/n WYK187697 land lying to the south of waingate, lower clough, linthwaite, hudderfield t/n WYK591854. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুল, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mezzanine security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage, all estates or interest in any real property being colville business centre, goliath way, hermitage estate for further property charged please refer to the form 395 by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Warner Estate, Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুল, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Gresley road, south western industrial estate, peterlee t/no DU191311 (f/h); site 1, glenfield business park, philips road, blackburn, lancashire t/nos LA524845 LA562580 (l/h) spring hall mills, mile cross road, halifax t/no WYK51717 (f/h) for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects k/a and forming traction house situated on the south side of hamilton road motherwell t/no LAN26055.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects k/a and forming motherwell business centre lying to the southwest side of dalziel street the southeast side of coursington road and northwest side of albert street motherwell t/no LAN136913.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects k/a and forming block 3 greenhill industrial estate coltswood road coatbridge t/no LAN53581.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects on the south side of main street coatbridge t/nos LAN74818 and LAN45798.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects known formerly as plot 10 and now as imex spaces business centre broadleys business park stirling t/no stg 39416.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole that plot or area of ground k/a and forming plot 2 carnegie campus dunfermline in the county of fife t/no ffe 44170.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from zipmodes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 30 september 2002 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects on the south side of hamilton road, motherwell and registered in the land register of scotland under t/no. Lan 26055.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 30 september 2002 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects extending to seventy six decimal or one hundredth parts of a hectare (0.76 hectares) or thereby at carnegie campus, dunfermline registered in the land registry of scotland under t/no. Ffe 44170.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee for Each of the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the company or by some other person) of the obligors (as defined) to the chargee (as trustee for the beneficiaries under (and as defined in) the trust agreement (as defined)) (or any of them) under each of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage the mortgage property (as defined), assigns all right title and interest to in and under all present and future collateral agreements to real property, licences granted to the company in respect of the real property, insurance policies and all proceeds paid or payable thereunder, first fixed charge all present and future assets, first floating charge all that heritable property of the company physically situated on the real property in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second ranking debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the company or by some other person) of the obligors (as defined) to the chargee (as trustee for the beneficiaries under (and as defined in) the trust agreement (as defined)) (or any of them) under each of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of second legal mortgage the mortgage property (as defined), assigns all right title and interest to in and under all present and future collateral agreements to real property, licences granted to the company in respect of the real property, insurance policies and all proceeds paid or payable thereunder, second fixed charge all present and future assets, second floating charge all that heritable property of the company physically situated on the real property in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the farfield road unit factory development 2/18 hillfort road , 92/98 hoyland road sheffield t/no;-SYK385540.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a wilsons park manchester t/no;-GM46446.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the cricket inn cricket inn road maltravers road derwent street sheffield t/no;-SYK394754.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H propertry k/a royd mill business park brighouse t/no;-WYK505418.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the hoyland road factory development 30/80 hoyland road sheffield SYK88618.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the hillford unit factory development hoyland road sheffield t/no;-SYK394671.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a londesborough street hull t/no;-HS186745.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a atlas business centre oxgate lane staples corner london t/no;-NGL498102.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a marsh mill luck lane marsh huddersfield t/no;-WYK377723.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a black rock mills linthwaite huddersfield t/no's;-WYK591854, WYK525399, WYK187697 and WYK561310.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    IMEX SPACES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৫ নভে, ২০১১ভেঙে গেছে
    ২৮ সেপ, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    অভ্যাসকারী
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0