ICE DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামICE DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01933851
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ARROWADD LIMITED২৬ জুল, ১৯৮৫২৬ জুল, ১৯৮৫

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২০

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ০১ নভে, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ নভে, ২০২১ তারিখে Mr Andrew Latham Nelson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ নভে, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ০১ নভে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ১৬ জানু, ২০২০ তারিখে Mr Paul Birch-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৬ জানু, ২০২০ তারিখে Mr Paul Birch-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ নভে, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ০২ সেপ, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Enterprise Holding Company No1 Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ০২ সেপ, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ থেকে Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1ABপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০১ নভে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ নভে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Enterprise Holding Company No1 Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ নভে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Latham Nelson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    সচিব
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    British76116640002
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    পরিচালক
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    পরিচালক
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector36191090004
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    British36153790001
    LAWSON, Robert William
    Tookey House Bullock Road
    Haddon
    PE7 3TS Peterborough
    Cambs
    সচিব
    Tookey House Bullock Road
    Haddon
    PE7 3TS Peterborough
    Cambs
    British17838300001
    LAYLEE, Graham Alexander
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    সচিব
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    British20268140002
    LEE, Sandra Dawn
    13 Whernside Way
    Leyland
    PR25 4ZN Preston
    Lancashire
    সচিব
    13 Whernside Way
    Leyland
    PR25 4ZN Preston
    Lancashire
    British74829960001
    WILLIAMS, Neil Edward
    57 Albany Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TX Preston
    Lancashire
    সচিব
    57 Albany Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TX Preston
    Lancashire
    British2927950001
    BROCKLEHURST, Charles Richard
    Pond Cottage
    48 Great Hampden
    HP16 9RS Great Missenden
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Pond Cottage
    48 Great Hampden
    HP16 9RS Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor39660240001
    DEWHURST, Andrew Paul
    6 Hill Top
    LA7 7RD Milnthorpe
    Cumbria
    পরিচালক
    6 Hill Top
    LA7 7RD Milnthorpe
    Cumbria
    BritishChartered Surveyor61272950001
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    পরিচালক
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller160883820001
    FURLONG, Gwynne Patrick
    Triggs Farm Fishwick Lane
    Higher Wheelton
    PR6 8HT Chorley
    Lancs
    পরিচালক
    Triggs Farm Fishwick Lane
    Higher Wheelton
    PR6 8HT Chorley
    Lancs
    EnglandBritishChartered Surveyor14172020001
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor61478920003
    HARRABIN, Ian David
    Loft 1 89 Turnmill Street
    EC1M 5QU London
    পরিচালক
    Loft 1 89 Turnmill Street
    EC1M 5QU London
    EnglandBritishChartered Surveyor14672310003
    HYNES, Michael Robert
    13 Chapman Road
    Fulwood
    PR2 8NX Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    13 Chapman Road
    Fulwood
    PR2 8NX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector2927960001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director51438040006
    LAYLEE, Graham Alexander
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    পরিচালক
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    BritishAccountant20268140002
    LOVELL, William Anthony
    Red Cottage Church Cliff
    Kingsdown
    CT14 8AT Deal
    Kent
    পরিচালক
    Red Cottage Church Cliff
    Kingsdown
    CT14 8AT Deal
    Kent
    BritishChartered Surveyor18677910001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17129800004
    NORTHEN, Robert Ian
    Rustlemere
    Nyetimber Copse
    RH22 2NE West Chiltington
    West Sussex
    পরিচালক
    Rustlemere
    Nyetimber Copse
    RH22 2NE West Chiltington
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor17838320001
    PORTER, Alan Redvers
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    BritishChartered Accountant17838310001
    SELLERS, Philip Edward
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director10598350001
    SPERBER, Marcus
    38 Willifield Way
    NW11 7XT London
    পরিচালক
    38 Willifield Way
    NW11 7XT London
    BritishChartered Surveyor69147520001
    TAYLOR, David Wilson
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    EnglandBritishChief Executive48552500002
    TAYLOR, David Wilson
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    EnglandBritishDirector48552500002
    THOMAS, Wyndham
    8 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    8 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishConsultant17838340001

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর2401383
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    ICE DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries(As Defined) (the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a development agreement dated 24TH december 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at wisbech road and black bank road littleport cambridgeshire t/no:CB232192.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • East Cambridgeshire District Council
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Barclays bank PLC re ice developments limited high interest business account number 90499064. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies now due or hereafter to become due from time to time accruing due from the company and/or enterprise PLC to the bank upon any account and in any manner whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land situate in watson street, middlesbrough, redcar and cleveland title number CE115947.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies now due or hereafter to become due or from time to time accruing due from the company and/or enterprise PLC to the bank upon any account and in any manner whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land situate on the east side of hay lane and the south side of bayley lane coventry known as 8,9, 10 & 10A hay lane, west midlands title number wm 550447.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The saveker funding as defined in the finance agreement of even date and all liabilities of the company to the chargee under or in respect of the finance agreement,the legal charge and costs and expenses incurred by the fund in enforcing the legal charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold land known as land at elkington st,aston,demised by a lease dated 17/1/97 (as defined) and the benefit of all development documents,all insurance policies and rents; fixed charge over recovery of vat,monies placed in development account and company rights in respect of the saveker site.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bri Tel Fund Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০২ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums of money deposited with the bank number 30998222 (see form 395 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details refer to doc M395 ref M193C & continuation sheets).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the east side of hay lane and south side of bayley lane together with buildings k/a 8, 9, 10 & 10A hay lane and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Unity Trust Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    7-57 (odd nos.) seymour street, liverpool and 96-100 (even nos.) london road, liverpool and 2-48 (even nos.) hart street, liverpool, merseyside title no. MS314905.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a cleveland business centre at the junction of russell street and watson street, middlesborough, cleveland, and all plant and machinery and other chattles thereon floating charge all unattached plant machinery and other chattels thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Unity Trust Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Sterling pounds 1,130,000 due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land situate on the east side of hay lane and the south side of bayley lane, coventry containing an area of 1299 sq. Metres approx.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Unity Trust Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property at city road, east manchester fixed charge over plant and machinery and other chattels, floating charge over all unattached plant and machinery and other chattels.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Two plots of land situate in and fronting to city road east, medlock street, glass street, river street and shortcroft street gaythorne, manchester, containing 0.55 hectares approx.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Standard form jct private with quantities building contract dated 25/5/90 made between john sisk & son (northern) LTD and the company.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Co-Operative Bank PLC.
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 29/1/90 as varied by a supplemental agreement dated 29/1/90
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a coronation buildings, south lambeth road, london SW8. Title no. Tgl 36625.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Mayor and Burgesses of the London Borough of Lambeth
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Coronation buildings, south lambeth road, vauxhall, l/b of lambeth part title no. Sgl 43528.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title & interst of the company in the development being a building agreement a grants agreement a task force agreement & in the land & premises.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Unity Trust Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land on the south east side of albion street manchester title no gh 456629. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The benefit of a building agreement see doc M513C for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Victoria works, graham st, birmingham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Unity Trust Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ ফেব, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All estate interest or right whatsoever of the company over the parcel of land having frontages to burley street & stockwell street greenwich london SE10 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The guildhall high street walsall, W.midlands title nos WM395514, wm 378336 WM399321.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 27-10-87.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Agreement dated 27-10-87 and land at burney street, and shoewell street, greenwich london SE10.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0