LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01936379
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • পারফিউম এবং প্রসাধনী সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসা (46450) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Newbury House Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Wiltshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CONSTANCE CARROLL LIMITED২০ অক্টো, ২০১১২০ অক্টো, ২০১১
    CONSTANCE CARROLL OVERSEAS LIMITED০৭ মে, ২০০৪০৭ মে, ২০০৪
    CONSTANCE CARROLL OVERSEAS PUBLIC LIMITED COMPANY২৫ নভে, ১৯৮৫২৫ নভে, ১৯৮৫
    CONSTANCE CARROLL (EXPORTS) LIMITED০৬ আগ, ১৯৮৫০৬ আগ, ১৯৮৫

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৯

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ৩০ জুল, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২২ অক্টো, ২০১৮ তারিখে Graham Murray Lynch Staunton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ আগ, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ১৬ ফেব, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lynne Margaret Lovell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ আগ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২০ সেপ, ২০১৭ তারিখে Susan Angela Lynch-Staunton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ জুল, ২০১৭ তারিখে Susan Angela Clayton-Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ জানু, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lynne Margaret Lovell-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ আগ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ ডিসে, ২০১৫

    ১৫ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০১ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Alan Thompson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed constance carroll LIMITED\certificate issued on 26/11/14
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২৬ নভে, ২০১৪

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    CONNOT

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LYNCH STAUNTON, Graham Murray
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director77490420006
    LYNCH-STAUNTON, Susan Angela
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritishUk Sales Director165079930008
    MUSHET, Norman Buchanan
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    সচিব
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    British105077220001
    RING, Leo Joseph
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    সচিব
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrishCo Secretary97021090001
    RING, Leo Joseph
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    সচিব
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrishCo Secretary97021090001
    ROBERTS, Timothy Edward
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    সচিব
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    British14876480002
    CARPENTER, Brian William
    Willan House
    Highland Road, Badgers Mount
    TN14 7BA Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Willan House
    Highland Road, Badgers Mount
    TN14 7BA Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishSales Director14876490002
    HICKIE, Gerard
    Higher House Farm
    Castle Mill Lane
    WA15 0RA Ashley
    Cheshire
    পরিচালক
    Higher House Farm
    Castle Mill Lane
    WA15 0RA Ashley
    Cheshire
    IrishManaging Director85735370004
    HUGHES, Loraine
    Walsham Gardens
    WA9 5UT St. Helens
    38
    Merseyside
    পরিচালক
    Walsham Gardens
    WA9 5UT St. Helens
    38
    Merseyside
    EnglandBritishFinance Director138239430001
    LOVELL, Lynne Margaret
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    Uk
    পরিচালক
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    Uk
    EnglandBritishFinance And Operations Director251923560001
    MARSH, Stephen Beverley
    Home Farm Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    পরিচালক
    Home Farm Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director36100180002
    MURPHY, James Michael
    36 Ulverton Road
    IRISH Dalkey
    Co Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    36 Ulverton Road
    IRISH Dalkey
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector51806010005
    MUSHET, Norman Buchanan
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    BritishAccountant105077220001
    O'BRIEN, Paul
    3 Fox Lodge Road
    Fox Lodge Woods
    IRISH Ratoath
    Ireland
    পরিচালক
    3 Fox Lodge Road
    Fox Lodge Woods
    IRISH Ratoath
    Ireland
    IrelandIrishDirector96999430001
    OTLEY, Richard Reverdy
    4 Osborne Way
    HP23 6EN Wiggington
    Hertfordshire
    পরিচালক
    4 Osborne Way
    HP23 6EN Wiggington
    Hertfordshire
    United KingdomBritishInvestment Analyst127085630001
    ROBERTS, Timothy Edward
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    BritishFinance Director14876480002
    SOROKIN, Alexander
    10 Sterling Street
    SW7 1HN London
    পরিচালক
    10 Sterling Street
    SW7 1HN London
    AmericanCorporate Financier111747170001
    THOMPSON, John Alan
    Grimrod Place
    East Gillibrands
    WN8 9UU Skelmersdale
    22
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Grimrod Place
    East Gillibrands
    WN8 9UU Skelmersdale
    22
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishSupply Chain Director60966890001
    WILKINSON, Alan Geoffrey
    1 Sunningdale Gardens
    Freshfield Road
    L37 3RL Formby Liverpool
    Merseyside
    পরিচালক
    1 Sunningdale Gardens
    Freshfield Road
    L37 3RL Formby Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director14876510002
    WILKINSON, Geoffrey Harold
    Dalton House Higher Lane
    Dalton
    WN8 7RP Wigan
    Lancashire
    পরিচালক
    Dalton House Higher Lane
    Dalton
    WN8 7RP Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director14876520001
    WILKINSON, Peter Alan
    Uplands
    Higher Lane, Dalton
    WN8 7TW Wigan
    Lancashire
    পরিচালক
    Uplands
    Higher Lane, Dalton
    WN8 7TW Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director87473650001

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষEnglish
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর1637008
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ আগ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed and machinery all stocks, shares & other securities.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0