MISYS SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMISYS SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01941076
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MISYS SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    MISYS SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MISYS SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CAMBRIDGE COMPUTER SERVICES LIMITED২১ আগ, ১৯৮৫২১ আগ, ১৯৮৫

    MISYS SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০১৪

    MISYS SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    13 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৪ আগ, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    20 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    4 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৫ আগ, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ 6 থেকে মুক্ত করা হয়েছে

    5 পৃষ্ঠাMR05

    ২০ জুল, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Johannes Jacobus Olivier-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ জুল, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Paul Woodward এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুন, ২০১৫

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Paul Woodward-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sanjay Patel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr John Van Harken-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Mary Collins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ জুন, ২০১৪

    ০৪ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Misys Corporate Director Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Joanna Hawkes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Misys Corporate Secretary Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Sanjay Patel-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Elizabeth Mary Collins-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Joanna Marageret Hawkes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Bijal Patel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    MISYS SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmericanCommercial Director183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant146605570001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanAccountant199516920001
    BICHEMO, Tracey Lynne
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    সচিব
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    British16560470002
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    সচিব
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    146638800001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    সচিব
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    সচিব
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    সচিব
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    সচিব
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    সচিব
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    সচিব
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর07036299
    170463660001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    পরিচালক
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant80646020001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant180406780001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant44954570001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinance Director56986700002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    BritishAccountant57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishAccountants75357260001
    FLANAGAN, Andrew Henry
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    পরিচালক
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    BritishFinance Director42787120001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    পরিচালক
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritishTreasurer136214800001
    JOHNSON, Russell Alan
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    পরিচালক
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    BritishAccountant130788060001
    MALONE, James Christopher
    Gloucester Park Apartments
    Ashburn Park
    SW7 4LL London
    Apartment 3g
    পরিচালক
    Gloucester Park Apartments
    Ashburn Park
    SW7 4LL London
    Apartment 3g
    Usa/IrishFinance Director122549240003
    MARSH, Howard Alexander David
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    পরিচালক
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    United KingdomBritishAccountant111938620001
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    পরিচালক
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritishCompany Director45080250003
    NICHOLSON, John William
    50 Exning Road
    CB8 0AB Newmarket
    Suffolk
    পরিচালক
    50 Exning Road
    CB8 0AB Newmarket
    Suffolk
    BritishManaging Director45395580001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    BritishGroup Company Director2546430001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritishFinance Director161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director147221810001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant1439590001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    পরিচালক
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant36622750002
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant100885620001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    One Kingdom Street
    W2 6BL Paddington
    Group Secretariat Misys Plc
    London
    কর্পোরেট পরিচালক
    One Kingdom Street
    W2 6BL Paddington
    Group Secretariat Misys Plc
    London
    132964180001

    MISYS SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৪ আগ, ২০১৫সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    MISYS SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ অক্টো, ২০১৭ভেঙে গেছে
    ২৫ আগ, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    অভ্যাসকারী
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0