MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01970801
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Tower Bridge House
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TAY HOMES (YORKSHIRE) LIMITED২৮ আগ, ১৯৯২২৮ আগ, ১৯৯২
    TAY HOMES (NORTHERN) LIMITED৩০ সেপ, ১৯৮৬৩০ সেপ, ১৯৮৬
    TAY HOMES (YORKSHIRE) LIMITED০৭ মার্চ, ১৯৮৬০৭ মার্চ, ১৯৮৬
    ALVERHILL LIMITED১৩ ডিসে, ১৯৮৫১৩ ডিসে, ১৯৮৫

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে Gavin Russell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    ০৯ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠা4.68

    ০৯ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১৪ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark David Peters এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Gavin Russell-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Stuart Leadill এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    4 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Stuart Kenneth Leadill-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Paul Goldsmith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ জুন, ২০১৩

    ০৫ জুন, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 372,000,000
    SH01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    32 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    ০১ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Paul William Goldsmith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BNOMS LIMITED
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    কর্পোরেট সচিব
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    67896020002
    PRYCE, Colin Michael
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    পরিচালক
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritish,Jamaican67971010001
    RUSSELL, Gavin
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    পরিচালক
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish188396180003
    BARTLETT, Paul Eugene
    Flat 3 Stable Mews
    Hillside Road
    AL1 3QR St Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    Flat 3 Stable Mews
    Hillside Road
    AL1 3QR St Albans
    Hertfordshire
    British54206450002
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    সচিব
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    British3621900001
    MCDONALD, Ross Edward
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    সচিব
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    British44092870001
    BANCROFT, Paul Andrew
    40 Cleveland Road
    Southwoodford
    E18 2AL London
    পরিচালক
    40 Cleveland Road
    Southwoodford
    E18 2AL London
    EnglandBritish99625640001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    পরিচালক
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    COLES, John Howard
    7 Victoria Terrace
    Headingley
    LS6 4BE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    7 Victoria Terrace
    Headingley
    LS6 4BE Leeds
    West Yorkshire
    British4462250001
    DOUGLASS, Peter William
    Bleak House 1 School Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6JS York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Bleak House 1 School Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6JS York
    North Yorkshire
    British4462240001
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish3621900001
    GALL, Terence
    232 Bradford Road
    WF1 2BA Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    232 Bradford Road
    WF1 2BA Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish37553160002
    GOLDSMITH, Paul William
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    পরিচালক
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    EnglandBritish28639100003
    HENDERSON, Ronald Andrew
    Frankleigh
    Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Frankleigh
    Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    United KingdomBritish2980400001
    HOWARD, Claire Lucie Mary
    Norsebury Cottage Winchester Road
    Micheldever
    SO21 3DG Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    Norsebury Cottage Winchester Road
    Micheldever
    SO21 3DG Winchester
    Hampshire
    British54519060001
    KNIGHT, Dawn Elizabeth
    2 Temperance Street
    AL3 4QA St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Temperance Street
    AL3 4QA St Albans
    Hertfordshire
    British19935890001
    LEADILL, Stuart Kenneth
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    পরিচালক
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish36282500001
    MARKHAM, Neal
    BD18
    পরিচালক
    BD18
    British29216140001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Cob Cottage
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    West Sussex
    পরিচালক
    Cob Cottage
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    West Sussex
    EnglandBritish34131020003
    MCDONALD, Ross Edward
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    পরিচালক
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    British44092870001
    MCGLONE, Roy Vickers
    11 Pearces Orchard
    Fairmile
    RG9 2LF Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    11 Pearces Orchard
    Fairmile
    RG9 2LF Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    British45248290001
    MURRAY, Stuart Fraser
    29 Binden Road
    W12 9RJ London
    পরিচালক
    29 Binden Road
    W12 9RJ London
    British675720001
    PARLOUR, John Leslie
    Red Roof Tithe Barn Lane
    Bardsey
    LS17 9DX Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Red Roof Tithe Barn Lane
    Bardsey
    LS17 9DX Leeds
    West Yorkshire
    British2494160001
    PEARSON, Christopher Rait O'Neill
    Shirley House, 5 West Walks
    DT1 1RE Dorchester
    Dorset
    পরিচালক
    Shirley House, 5 West Walks
    DT1 1RE Dorchester
    Dorset
    British60365730001
    PETERS, Mark David
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    পরিচালক
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish192348430001
    STUBBS, Norman Alan
    East Chevin Road
    LS21 3DD Otley
    The Stables
    West Yorkshire
    পরিচালক
    East Chevin Road
    LS21 3DD Otley
    The Stables
    West Yorkshire
    EnglandBritish1692650001
    TYSON, Christopher Roberto
    Pemberley Gregorys Meadow
    Stourscombe
    PL15 9QZ Launceston
    Cornwall
    পরিচালক
    Pemberley Gregorys Meadow
    Stourscombe
    PL15 9QZ Launceston
    Cornwall
    British4093740001

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and premises k/a 20 middlecroft road stourton grange middleton leeds west yorkshire t/n WYK254776. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 14 ruffa lane pickering ryedale north yorkshire t/NNYK65314.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 6 beck hill buttershaw north bierley bradford west yorkshire t/n WYK113069. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 24 rayner avenue bradford west yorkshire and registered under t/n WYK287817. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 28 teall court ossett wakefield west yorkshire t/n WYK89112. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 1 cedar close scawby glanford humberside. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fr/h land and blds--8 ringley meadows bempton,east yorkshire.t/no.hs 144650 fixed charge--all covenants and rights the plant,machinery,fixtures,fittings furniture....etc. See form 395.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 10 victoria avenue filey scarborough north yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a sunnybank road mirfield west yorkshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 178 wortley road high green sheffield south yorkshire t/n SYK430. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 9 highfield road north thorseby east lindsey lincolnshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 10 fern road walkley sheffield south yorkshire t/n YWE22948. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 20 kingsdale avenue drighlington leeds west yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold land and blds--91 carr rd, calverley,leeds,west yorkshire. T/no.wyk 417667. fixed charge--the benefit of all covenants and rights......the plant, machinery,fixtures,fittings,furniture, equipment,implements and utensils now and in the future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land and blds--8 haigh side driverothwell,leeds,west yorkshire.t/no.wyk 114469 fixed charge--the benefit of all covenants and rights,the plant,machinery fixtures,fittings,furniture,equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land and blds--29 nab wood terrace,shipley,bradford,west yorkshire t/no.wyk 42418 fixed charge--the benefit of all covenants and rights,the plant,machineryfixtures,fittings,furniture,equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage f/h land and premises k/a 20 southwold scarborough N. yorks. Inc: fixtures and fittings (see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a 34 siver royd road wortley leeds W.yorks title no: WYK413215 inc: fixtures and fittings (see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and blds--5 mere view gardens scarborough,north yorkshire fixed charge--all covenants and rights...,..the plant,machinery,fixtures,fittings,furniture...etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 5 manor close long street topcliffe hambleton north yorkshire t/n NYK54632. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 50 lidget lane skelmanthorpe kirklees west yorkshire t/n WYK75281. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 140 quaker lane cleckheaton kirklees west yorkshire t/n wyk 335778. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 21 ackroyd street morley leeds west yorkshire t/n wyk 84243. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    3 pumping station cottages,dunswell lanebeverley,humberside.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings k/a 6 carr lane tankersley barnsley south yorkshire t/n SYK41703. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১০ ডিসে, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৫ জানু, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    অভ্যাসকারী
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    অভ্যাসকারী
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0