L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামL & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01994706
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9305) /

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    10 Grosvenor Street
    London
    W1K 4BJ
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CANNON STREET DEVELOPMENT GROUP LIMITED২০ জুন, ১৯৮৬২০ জুন, ১৯৮৬
    DROPANGEL LIMITED০৩ মার্চ, ১৯৮৬০৩ মার্চ, ১৯৮৬

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    2 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Berger-North এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Thomson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Lawrence Hutchings এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Peter Cole এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Martin Jepson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বিবিধ

    Memorandum of capital 21/10/09
    1 পৃষ্ঠাMISC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Canc share prem accnt to zero
    RES13

    পরিচালক হিসাবে David Atkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    5 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    5 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    5 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HAYDON, Stuart John
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    সচিব
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British3175210001
    HARDIE, Nicholas Alan Scott
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    পরিচালক
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    EnglandBritish56627250001
    AITON, John
    Burstall Hall
    Burstall
    IP8 3DW Ipswich
    Suffolk
    সচিব
    Burstall Hall
    Burstall
    IP8 3DW Ipswich
    Suffolk
    British847420002
    HOLLOCKS, Ian Michael
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    সচিব
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    British61055270001
    JONES, Gary Stanley
    Hawes Cottage 52 Hawes Lane
    BR4 0DB West Wickham
    Kent
    সচিব
    Hawes Cottage 52 Hawes Lane
    BR4 0DB West Wickham
    Kent
    British885400001
    ALFORD, Nicholas Brian Treseder
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Great BritainBritish126970360001
    ATKINS, David John
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish144036070001
    BAKER, Michael John
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    পরিচালক
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    British77729120001
    BERGER-NORTH, Andrew John
    Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    1
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    1
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish134630050001
    BYWATER, John Andrew
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish71820020003
    COLE, Peter William Beaumont
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish51145990001
    DAVIES, Stephen Jeremy
    75 Vineyard Hill Road
    Wimbledon
    SW19 7JL London
    পরিচালক
    75 Vineyard Hill Road
    Wimbledon
    SW19 7JL London
    EnglandBritish18128510001
    EMERY, Jonathan Michael
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    পরিচালক
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    British78621400001
    EVANS, Christopher Mark Stephen
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    পরিচালক
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    EnglandBritish71333340001
    HARRIS, Christopher Ian Knowles
    Church End Cottage
    Church End
    HP27 9PE Bledlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Church End Cottage
    Church End
    HP27 9PE Bledlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish32552620001
    HARRIS, Iain Farlane Sim
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    পরিচালক
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritish56363000001
    HEWSON, Andrew Nicholas
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    পরিচালক
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British8607090005
    HUBERMAN, Paul Laurence
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    পরিচালক
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    EnglandBritish3470530003
    HUTCHINGS, Lawrence Francis
    Brody House
    Strype Street
    E1 7LQ London
    Flat 503
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brody House
    Strype Street
    E1 7LQ London
    Flat 503
    United Kingdom
    EnglandBritish134630060001
    JEPSON, Martin Clive
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish92627900001
    THOMSON, Andrew James Gray
    Niton Street
    SW6 6NJ London
    10
    পরিচালক
    Niton Street
    SW6 6NJ London
    10
    EnglandBritish97267360001
    WALTON, Timothy Paul
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    পরিচালক
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish59971310002
    WARMAN, John Albert
    32 Barns Dene
    AL5 2HQ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    32 Barns Dene
    AL5 2HQ Harpenden
    Hertfordshire
    British12171540001
    WRIGHT, Geoffrey Harcroft
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    পরিচালক
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    British8585700001

    L & M PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    From 22.2.91 unitl the implementation date all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as trustee for the banks (as defined) under the terms of the working capital facility, the finance documents, the existing facilities (all as defined) and this deed and all amounts of non-shortfall debt owing to barclays bank PLC by rowanspon limited under the reigate facility, up to a maximum of £4,610,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All estate, right of interest (if any) of the company in 10 church terrace, richmond,surrey. Richmond-upon thames title no. Sgl 342396 (please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Banks.
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    10 church terrace richmond, surrey. T/no: sgl 242396. fixed charge: benefit of all of the building contract the right, title and interest to and in any proceeds of present & future insurances. Monies payable pursuant to any letting of the property (see 395 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0