CAMTRO LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCAMTRO LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02003533
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CAMTRO LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CAMTRO LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CAMTRO LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SELF-CHANGING GEARS LIMITED১০ জুন, ১৯৮৬১০ জুন, ১৯৮৬
    EAGERCRAFT LIMITED২৫ মার্চ, ১৯৮৬২৫ মার্চ, ১৯৮৬

    CAMTRO LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    CAMTRO LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CAMTRO LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    ০৩ জুল, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Warwick House PO Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৬ জুন, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ সেপ, ২০১৪

    ১৭ সেপ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,643,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ সেপ, ২০১৩

    ১০ সেপ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,643,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ নভে, ২০০৯ তারিখে David Stanley Parkes-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০৬ নভে, ২০০৯ তারিখে David Stanley Parkes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৩ নভে, ২০০৯ তারিখে Ann Louise Holding-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    CAMTRO LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    সচিব
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    HOLDING, Ann-Louise
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    পরিচালক
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish73464490003
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    পরিচালক
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish25179240002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    সচিব
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    সচিব
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GOULDING, Jacqueline Elizabeth
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    সচিব
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    British49027500001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    সচিব
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    LANGLEY, Paul Michael
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    সচিব
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    British47929580002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    পরিচালক
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GREENSLADE, Martin Frederick
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish17633990002
    HOYLE, David John
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    British17280400001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    পরিচালক
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    MITCHELL, Stuart Roger
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    New Zealand1447530001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    ROWE, Christopher Gordon
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    পরিচালক
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    British113894430001
    WEBSTER, Donald James
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    British37379940001
    WINCH, Brian Clappison
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    EnglandBritish64371830001

    CAMTRO LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over all undertaking property assets and revenues.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alvis PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment and charge of registered designs and design right
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment and charge of copyright and design rights
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of trade marks, trade names and goodwill
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment and charge of patents
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All inventions and patents specified in form 395 together with all inventions and patents belonging to the mortgagor present and future at the date of the charge. Patent no's: 5031477. 0 420 446 (e) (X2). 2172 672. 2235663. P690 01 168.7 14889/1990. 5 031 477.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Each of the Banks
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Each of the Banks
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession and supplemental charge.
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this deed.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M395-ref M816 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trade marks mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All trade marks and applications for trade marks as defined on form M395 reg M137.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Patents charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All inventions and patents as defined on form M395 reg M127.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclayds Bank Plcd in the Deed)(For Itself and as Agent for the Banks as Define
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Designs charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All designs as defined on form M395, reg M117.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of copyright
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All copyrights, design rights and rights defined on form M395, reg M107.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CAMTRO LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩১ মার্চ, ২০১৬ভেঙে গেছে
    ১৬ জুন, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0