MMH NSS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMMH NSS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02008285
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MMH NSS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ধাতু এবং ধাতব আকরিকের পাইকারি ব্যবসা (46720) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    MMH NSS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MMH NSS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NEWTON STEEL STOCK LIMITED২১ আগ, ১৯৮৬২১ আগ, ১৯৮৬
    LOCALBARTER LIMITED০৯ এপ্রি, ১৯৮৬০৯ এপ্রি, ১৯৮৬

    MMH NSS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৩

    MMH NSS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বিবৃতির বিবৃতি

    পৃষ্ঠা4.20

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার - পূর্বে ঋণদাতাদের স্বেচ্ছায় দ্রবীভূতকরণে

    3 পৃষ্ঠাREST-CVL

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    15 পৃষ্ঠা4.72

    ১৮ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    16 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    একটি লিকুইডেটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠা4.33

    ১৯ ফেব, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O C/O Gateley Llp One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ থেকে Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TRপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন ০৫ জানু, ২০১৫ তারিখে

    LRESEX

    বিবৃতির বিবৃতি

    4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    ২১ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Graeme Everitt Hill এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ জুল, ২০১৪

    ১৭ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 91,090
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ জুল, ২০১৩

    ১৭ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed newton steel stock LIMITED\certificate issued on 22/05/12
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    ২২ মে, ২০১২

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    পরিচালক হিসাবে David Lawson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    MMH NSS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HORNE, David William Murray
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    সচিব
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British41593900004
    LOCKYER, Ian Paul
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    পরিচালক
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish67618470001
    MCGILL, Michael Scott
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    পরিচালক
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    ScotlandBritish99070570001
    NEWELL, Robert Nigel
    Holly Croft Grove Lane Close
    Stalbridge
    DT10 2RF Sturminster Newton
    Dorset
    সচিব
    Holly Croft Grove Lane Close
    Stalbridge
    DT10 2RF Sturminster Newton
    Dorset
    British4580220001
    WAIT, Jennifer Joan
    Hedgerow
    East Stour Common, East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    সচিব
    Hedgerow
    East Stour Common, East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    British17613870001
    FAYERS, Trevor Paul
    3 Gower Road
    SP7 8RU Shaftesbury
    Dorset
    পরিচালক
    3 Gower Road
    SP7 8RU Shaftesbury
    Dorset
    United KingdomBritish67618490001
    HILL, Graeme Everitt
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    পরিচালক
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    EnglandBritish144984260001
    LAWSON, David Barrie
    Penshaw House 5 Pinfold Lane
    Misterton
    DN10 4FE Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Penshaw House 5 Pinfold Lane
    Misterton
    DN10 4FE Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish122575270001
    MAYNARD, Alfred Henry Charles
    Weston House
    Stalbridge Weston
    DT10 2LA Sturminster Newton
    Dorset
    পরিচালক
    Weston House
    Stalbridge Weston
    DT10 2LA Sturminster Newton
    Dorset
    United KingdomBritish141663640001
    NEWELL, Robert Nigel
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    পরিচালক
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    United KingdomBritish4580220001
    VINING, Christopher Noel
    The Vicarage
    Stourton Caundle
    DT10 2JH Sturminster Newton
    Dorset
    পরিচালক
    The Vicarage
    Stourton Caundle
    DT10 2JH Sturminster Newton
    Dorset
    EnglandBritish141663630001
    WAIT, Gordon
    Hedgerow
    East Stour Common East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    পরিচালক
    Hedgerow
    East Stour Common East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    British17613890001
    WILSON, James Donald Gilmour
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    পরিচালক
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    ScotlandBritish69298770001

    MMH NSS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H and l/h property at unit 3 city business centre, basin road, chichester t/no WSX115019 and the property formerly at henstridge airfield and to the north of landshire lane, henstridge t/no's WS30409, WS10242, ST169615, ST117114 and ST106352 and fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মে, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুল, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property lying to the north of landshire lane hestridge airfield henstridge somerset t/n ST106352 WS10242 ST169615 ST117114 and WS30409. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুল, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 3 city business centre basin road chichester west sussex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 7 thrift close stalbridge north dorset.t/no.DT196329.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility to provide finance for the purchase of the property mortgaged
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property at 7 thrift close,stalbridge,dorset. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a gibbs marsh trading estate landshire lane henstridge somerset t/nos. ST67891 and ST71108 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property known as warehouse and land at station rd, sturminster newton, dorset.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MMH NSS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৫ জানু, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    William Kenneth Dawson
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    অভ্যাসকারী
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    অভ্যাসকারী
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Christopher Mckay
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    অভ্যাসকারী
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0