RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামRICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02017015
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বর্জ্য এবং স্ক্র্যাপের পাইকারি ব্যবসা (46770) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Kendal House
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ জুন, ২০১৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০১৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৩

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১১ আগ, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৫ আগ, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    2 পৃষ্ঠাAC92

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ৩০ নভে, ২০১৬ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    20 পৃষ্ঠা2.35B

    ২৫ মে, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    20 পৃষ্ঠা2.24B

    ২৫ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    17 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১১ আগ, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 93 Queen Street Sheffield S1 1WF থেকে Kendal House 41 Scotland Street Sheffield S3 7BSপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ০১ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    17 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    35 পৃষ্ঠা2.17B

    ১০ ডিসে, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Clement Works Clement Street Sheffield South Yorkshire S9 5EA থেকে 93 Queen Street Sheffield S1 1WFপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    ৩০ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Fransiscus Wilhelm Leonard Van Ommeren এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ আগ, ২০১৪

    ১৫ আগ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000
    SH01

    ২৩ জুল, ২০১৪ তারিখে Geoffrey Bingham-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৩ জুল, ২০১৪ তারিখে Geoffrey Bingham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পরিচালক হিসাবে David Hedley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    26 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Fransiscus Wilhelm Leonard Van Ommeren-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ সেপ, ২০১৩

    ১৭ সেপ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    20 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Capitalise the sum of £30,463 company reserves directors authorised to pay up in full 30,463 preference shares of £1 each to be allotted and credited as fully paid 19/06/2013
    RES13

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ চার্জ 2 থেকে মুক্ত করা হয়েছে

    5 পৃষ্ঠাMR05

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ চার্জ 3 থেকে মুক্ত করা হয়েছে

    5 পৃষ্ঠাMR05

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ চার্জ 7 থেকে মুক্ত করা হয়েছে

    5 পৃষ্ঠাMR05

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ চার্জ 6 থেকে মুক্ত করা হয়েছে

    5 পৃষ্ঠাMR05

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BINGHAM, Geoffrey
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    Kendal House
    সচিব
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    Kendal House
    British9552420001
    BINGHAM, Geoffrey
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    Kendal House
    পরিচালক
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    Kendal House
    United KingdomBritish9552420001
    FLETCHER, Richard Paul
    Beauchief Hall
    Beauchief Drive
    S8 7BA Sheffield
    The Stables
    South Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Beauchief Hall
    Beauchief Drive
    S8 7BA Sheffield
    The Stables
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish47471610003
    FLETCHER, Susan
    Wayside Sloade Lane
    Ridgeway
    S12 3YA Sheffield
    সচিব
    Wayside Sloade Lane
    Ridgeway
    S12 3YA Sheffield
    British47471570001
    HEDLEY, David Martin
    35 Twentywell View
    Bradway
    S17 4PX Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    35 Twentywell View
    Bradway
    S17 4PX Sheffield
    South Yorkshire
    British78788520001
    BELL, Roger
    6 Kirkstall Close
    Brinsworth
    S60 5NP Rotherham
    South Yorkshire
    পরিচালক
    6 Kirkstall Close
    Brinsworth
    S60 5NP Rotherham
    South Yorkshire
    British20690080001
    FLETCHER, Susan
    Wayside Sloade Lane
    Ridgeway
    S12 3YA Sheffield
    পরিচালক
    Wayside Sloade Lane
    Ridgeway
    S12 3YA Sheffield
    United KingdomBritish47471570001
    HEDLEY, David Martin
    35 Twentywell View
    Bradway
    S17 4PX Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    35 Twentywell View
    Bradway
    S17 4PX Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish78788520001
    VAN OMMEREN, Frans Wilhelm Leonard
    Clement Works
    Clement Street
    S9 5EA Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Clement Works
    Clement Street
    S9 5EA Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomDutch192211250002

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule or any part thereof, 1 x lindermann 575 shear no TF3 3BP,1 x sennebogan 821M crane no 8210187,1 x sennebogan SM15 crane no 51505314 (for details of further chattels charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 7 acres of land, newbridge lane, old whittington, chesterfield. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things describe in the schedule being 1 x sennebogen 825 27 ton wheeled materials handler no 825.0.229 (2002) with rossi tine grab, generator & magnet. 1 x sennebogan 821 21 ton wheeled materials handler no. 821.0.173 (2001) with generator & magnet. 1 x scania 94D rigid chassis fitted with jack allen p/sweeper 60 road sweeping body no S0138 1 a 98 registration number R107 sjw. For further details of equipment charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    RICHARD FLETCHER (METALS) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০১ ডিসে, ২০১৪প্রশাসন শুরু
    ৩০ নভে, ২০১৬প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Ashleigh William Fletcher
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    অভ্যাসকারী
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    অভ্যাসকারী
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0