ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামASTEC COMMUNICATIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02023193
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RANGENOW LIMITED২৮ মে, ১৯৮৬২৮ মে, ১৯৮৬

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৯

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ২৩ ফেব, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Janine Butler-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ফেব, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Nigel Evans এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ ফেব, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ১৪ ফেব, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    256 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    2 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    ০২ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Michael Yorston-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Diane Josephine Mcintyre এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ ফেব, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ১৪ ফেব, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর2357692
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    সচিব
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    সচিব
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HODGSON, Mark
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    সচিব
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    সচিব
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    সচিব
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    সচিব
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    পরিচালক
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    British54076100002
    BARR, Robert Nicolas
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    UkBritish41968920003
    BEST, Pauline Ann
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    British68015830001
    BISWAS, Sumit Kumar
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    British63870460001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    পরিচালক
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    পরিচালক
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    পরিচালক
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    British50867930001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    পরিচালক
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British27272400002
    HEXT, Jane Helen
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish152305810001
    HILLHOUSE, George Reid
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    British2899430001
    HODGSON, Mark
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060002
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    British55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    পরিচালক
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MAXWELL, Ian Ronald
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    British16186890001

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর3381659
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15TH july 1996
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £10,868.75 or any increased sum payable into the deposit account in the name of the landlord at lloyds babk PLC. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ravenseft Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £5,000 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of an underlease of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A rent deposit of £5,000 paid under a deed dated the 8/7/96. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ravenseft Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 12TH july 1995 and/or this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £11,163.50.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company`s right title and interest in and to the subscriber base al book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements dated 28/93 and 3/2/93 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The interest of the company in its customers from time to time as well as after as before any receiver may be appointed. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Vodafone Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Vodafone Group PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Telecom Securicor Cellular Radiw Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ২৮ জুল, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ নভে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements, all bills of exchange or promissory notes, all guarantees indemnities bonds or other securities. (For full details please see form 395 ref: M173/26NOV/ln).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ নভে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0