POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPOWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02039387
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Jeyes
    Brunel Way
    IP24 1HF Thetford
    Norfolk
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PROFESSIONAL LIQUID PRODUCTS LIMITED১৯ ফেব, ১৯৯০১৯ ফেব, ১৯৯০
    PROFESSIONAL FILLERS (UK) LIMITED২২ জুল, ১৯৮৬২২ জুল, ১৯৮৬

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    5 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ মার্চ, ২০১৫

    ১৬ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 35,100
    SH01

    ১৯ ফেব, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Tennyson House Cambridge Business Park Cambridge Cambridgeshire CB4 0WZ থেকে Jeyes Brunel Way Thetford Norfolk IP24 1HFপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew John Simpson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Loraine Hughes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ মার্চ, ২০১৪

    ২৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 35,100
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Gregor Miller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mrs Loraine Hughes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Nicholas Goodwin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Nicholas Goodwin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ আগ, ২০১১ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAA03

    বিবিধ

    Section 519
    2 পৃষ্ঠাMISC

    পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SIMPSON, Andrew John
    Brunel Way
    IP24 1HF Thetford
    Jeyes
    Norfolk
    England
    পরিচালক
    Brunel Way
    IP24 1HF Thetford
    Jeyes
    Norfolk
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer105165150001
    GOODWIN, Nicholas David
    Uplands Farmhouse Chandlers Road
    Stoke Holy Cross
    NR14 8RE Norwich
    Norfolk
    সচিব
    Uplands Farmhouse Chandlers Road
    Stoke Holy Cross
    NR14 8RE Norwich
    Norfolk
    BritishDirector49424950001
    GREAVES, Mark Andrew
    11 Carnoustie Close
    DH8 5XQ Consett
    County Durham
    সচিব
    11 Carnoustie Close
    DH8 5XQ Consett
    County Durham
    British56481200003
    STEVENSON, Damian Jon
    2 Manor Court
    Heighington Village
    DL5 6TL Newton Aycliffe
    County Durham
    সচিব
    2 Manor Court
    Heighington Village
    DL5 6TL Newton Aycliffe
    County Durham
    BritishFinance Director & Co Sec99020240002
    THACKWRAY, Denis
    13 Purbeck Gardens
    NE23 9QG Cramlington
    Northumberland
    সচিব
    13 Purbeck Gardens
    NE23 9QG Cramlington
    Northumberland
    British26756080001
    WELFORD, John Audus
    27 Beverley Gardens
    Cullercoats
    NE30 4NS North Shields
    Tyne & Wear
    সচিব
    27 Beverley Gardens
    Cullercoats
    NE30 4NS North Shields
    Tyne & Wear
    British26756120001
    ADAMS, John Bruce
    Bury Road
    Sicklesmere
    IP30 0BS Bury St Edmunds
    The Barn House
    Suffolk
    পরিচালক
    Bury Road
    Sicklesmere
    IP30 0BS Bury St Edmunds
    The Barn House
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector129805310001
    BURDETT, Roger Leonard
    The Common
    Colley Moor
    CV78AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Common
    Colley Moor
    CV78AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector163337290001
    CUMMINS, Julian Peter Francis
    50 Lane End
    Pudsey
    LS28 9AD Leeds
    Westyorkshire
    পরিচালক
    50 Lane End
    Pudsey
    LS28 9AD Leeds
    Westyorkshire
    BritishCompany Director20960930004
    GLENDINNING, Donald
    19 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    19 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director26756090001
    GOODWIN, Nicholas David
    Uplands Farmhouse Chandlers Road
    Stoke Holy Cross
    NR14 8RE Norwich
    Norfolk
    পরিচালক
    Uplands Farmhouse Chandlers Road
    Stoke Holy Cross
    NR14 8RE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector49424950001
    GREAVES, Mark Andrew
    11 Carnoustie Close
    DH8 5XQ Consett
    County Durham
    পরিচালক
    11 Carnoustie Close
    DH8 5XQ Consett
    County Durham
    United KingdomBritishAccountant56481200003
    HUGHES, Loraine
    Cambridge Business Park
    CB4 0WZ Cambridge
    Tennyson House
    Cambridgeshire
    England
    পরিচালক
    Cambridge Business Park
    CB4 0WZ Cambridge
    Tennyson House
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritishAccountant138239430001
    MILLER, Gregor Arthur Livingstone
    Birkdale Court
    Fornham St. Martin
    IP28 6XF Bury St. Edmunds
    11
    Suffolk
    পরিচালক
    Birkdale Court
    Fornham St. Martin
    IP28 6XF Bury St. Edmunds
    11
    Suffolk
    EnglandBritishCompany Director129805390002
    PARR, Matthew
    8 Middleton Close
    Burnside
    DH8 7UQ Consett
    County Durham
    পরিচালক
    8 Middleton Close
    Burnside
    DH8 7UQ Consett
    County Durham
    BritishIndustrial Chemist56481280002
    PEVELLER, Neil
    4 Lydgate Avenue
    Wolsingham
    DL13 3LJ Bishop Auckland
    County Durham
    পরিচালক
    4 Lydgate Avenue
    Wolsingham
    DL13 3LJ Bishop Auckland
    County Durham
    United KingdomBritishOperations Director119068610001
    SAUNDERS, Anna Louise
    29a Linden Road
    Gosforth
    NE3 4EY Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    29a Linden Road
    Gosforth
    NE3 4EY Newcastle Upon Tyne
    BritishCommercial Director75110670003
    STEVENSON, Damian Jon
    2 Manor Court
    Heighington Village
    DL5 6TL Newton Aycliffe
    County Durham
    পরিচালক
    2 Manor Court
    Heighington Village
    DL5 6TL Newton Aycliffe
    County Durham
    United KingdomBritishCo Secretary & Financial Direc99020240002
    THOMPSON, David Noble
    32 Beverley Gardens
    Cullercoats
    NE30 4NS North Shields
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    32 Beverley Gardens
    Cullercoats
    NE30 4NS North Shields
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director26756100001
    WELFORD, Glen Audus
    68 Highbury
    NE2 3LN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    68 Highbury
    NE2 3LN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director26756110002
    WELFORD, John Audus
    27 Beverley Gardens
    Cullercoats
    NE30 4NS North Shields
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    27 Beverley Gardens
    Cullercoats
    NE30 4NS North Shields
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director26756120001

    POWDER AND LIQUID PRODUCTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a unit bt 101/37 no. 1 industrial estate consett county durham comprised in a lease dated 2.5.90.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Audus Noble Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit bt 101/37 no. 1 industrial estate consett co. Durham.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 17/4/89
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest of the company arising out of a receivables financing agreement dated 25.2.88. (see doc for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Coal Enterprise Limited.
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0